CAMCO DRILLING GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CAMCO DRILLING GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI020719 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | L'Estrange & Brett Arnott House BT1 1LS 12/16 Bridge Street Belfst |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
REED TOOL COMPANY LIMITED | 10. Juli 1987 | 10. Juli 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Nov Downhole Eurasia Limited as a person with significant control on 21. Mai 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alastair James Fleming als Geschäftsführer am 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Scott Reid als Direktor am 09. Juli 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Robbert Oudendijk als Direktor am 30. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Paul O'neil als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Paul O'neil am 22. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gregor Ritchie als Sekretär am 28. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gregor Ritchie als Geschäftsführer am 28. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alastair James Fleming am 07. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Paul O'neil am 07. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOAN, Alison May | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
OUDENDIJK, Robbert | Geschäftsführer | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | Vice President Finance Europe, Mena, Cis | 201609020001 | ||||
REID, Simon Scott | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | Accountant | 248254430001 | ||||
FLEMING, Alastair James | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163580800001 | |||||||
O'NEIL, Christopher Paul | Sekretär | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire | 152547890001 | |||||||
RITCHIE, Gregor | Sekretär | The Beeches Dr Crouch's Road GL6 7EA Eastcombe ,Stroud Gloucs | British | 89385880001 | ||||||
BARR, John D | Geschäftsführer | 2 Charlton Park Gate Cheltenham GL53 7DJ Glos | British | Director | 144402910001 | |||||
BOYLE, Thomas Douglas | Geschäftsführer | Lanark, Old Inn Road Findon AB12 3RT Portlethen Aberdeen | Uk | British | Finance Director Uk | 61611910001 | ||||
CALDWELL, Robert J | Geschäftsführer | 3315 Boca Raton Quail Valley 77459 Missouri City Texas Usa | British | Co President | 144402960001 | |||||
CANAVAN, Damien Charles | Geschäftsführer | 70 Knock Eden Park Belfast BT6 OJG | Northern Ireland | Irish | Accountant | 51383240001 | ||||
FLEMING, Alastair James | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | Uk Country Controller | 180854890001 | ||||
GREEN, Joseph Scott | Geschäftsführer | Bluebonnetts Whitminster Lane GL2 7HR Frampton On Seven Glos. | England | British | General Manager | 144402920001 | ||||
KEENER, David James | Geschäftsführer | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | Company Director | 161469350001 | ||||
O'NEIL, Christopher Paul | Geschäftsführer | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire Scotland | United Kingdom | British | Vp Finance | 162062160001 | ||||
RAY, Neil | Geschäftsführer | 72 Defoe House Barbican EC27 8DN London England | British | Accountant | 144402980001 | |||||
RITCHIE, Gregor | Geschäftsführer | The Beeches Dr Crouch's Road GL6 7EA Eastcombe Stroud | England | British | Commercial Director | 89385880001 | ||||
ROBERTS, Maurice Anthony | Geschäftsführer | 2626 Salado Drive Woodbend 77584 Silverlatce Brazoria County, Texas | British | Financial Director | 4172750003 | |||||
SMYTH, George Anthony | Geschäftsführer | 8 Orchard Crescent BT30 6NY Downpatrick County Down | British | Accountant | 51383250003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAMCO DRILLING GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov Downhole Eurasia Limited | 06. Apr. 2016 | Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CAMCO DRILLING GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 26. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies composite debenture.. 1. fixed security. The company charges to the administrative agent by way of fixed charge as beneficial owner and as continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities all of the company's rights to and title and interest from time to time in any and each of the following:. 1.1 all of its securities; and. 1.2 the shares.. See 402 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 26. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Debenture - all monies. 1. floating security. The company charges to the administrative agent by way of first floating charge with full title guarantee, as beneficial owner and as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities all of the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of the property assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever , present and future......see 402 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0