FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI024037 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 50 Bedford Street Belfast BT2 7FW |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
IAN PENNICK LIMITED | 20. Juni 1991 | 20. Juni 1991 |
RETAIL SOFTWARE TECHNOLOGY LTD | 10. Jan. 1990 | 10. Jan. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2003 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Graeme Cooksley als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Ms Amanda Jane Gradden als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 5 Seiten | 371S(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 411B(NI) | ||
legacy | 7 Seiten | 371S(NI) | ||
legacy | 2 Seiten | 296(NI) | ||
legacy | 4 Seiten | 296(NI) | ||
legacy | 2 Seiten | 296(NI) | ||
legacy | 1 Seiten | 233(NI) | ||
legacy | 6 Seiten | 371S(NI) | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADDEN, Amanda Jane | Geschäftsführer | 50 Bedford Street Belfast BT2 7FW | England | British | Chartered Accountant | 77425910003 | ||||
COOKSLEY, Graeme Roy | Sekretär | Chamber Russweg 19 Switzerland 6300 ZUG | 143679430001 | |||||||
HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | 143679400001 | |||||||
ISAACSON, Kirk | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive Saint Charles 60174 Illinois Usa | 143679250001 | |||||||
LEEK, Marcus | Sekretär | 7 Gloster Drive Kenilworth CV8 2YU Warwickshire | 143679230001 | |||||||
THOMPSON, Richard James | Sekretär | 19 Fairfields Drive Ravenshead NG15 9HR Nottingham Nottinghamshire | 143679260001 | |||||||
THOMPSON, Richard James | Sekretär | 19 Fairfields Drive Ravenhead NG15 9HR Nottingham Nottinghamshire | 143679270001 | |||||||
DAY, Robert William | Geschäftsführer | Weathertop Blackmires Lane NN12 8Z Silverstone Northants | British | Director | 143679350001 | |||||
HORN, Nigel David | Geschäftsführer | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | Lawyer | 143679390001 | |||||
ISAACSON, Kirk | Geschäftsführer | 1110 Fox Glen Drive Saint Charles 60174 Illinois Usa | American | Director | 143679240001 | |||||
LEEK, Marcus | Geschäftsführer | 7 Closter Drive Kenilworth CV8 2TU Warwickshire | British | Director | 143679420001 | |||||
LOOSEMORE, Robert William | Geschäftsführer | 7 Crick Road Oxford OX2 6QJ Oxfordshire | Director | 143679380001 | ||||||
MATTHEWS, Philip Hunter | Geschäftsführer | 14 Barony Terrace Edinburgh EH12 8RE | United Kingdom | British | Director | 75582170001 | ||||
MORELLI, Stephen | Geschäftsführer | 49 Lagmore Downs Belfast BT17 0TB | British | Computer Consultant | 143679310001 | |||||
PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
PENNICK, Colette | Geschäftsführer | 75 Ardmore Heights Holywood BT18 0PY | British | Marketing Consultant | 143679300001 | |||||
PENNICK, Ian G | Geschäftsführer | 75 Ardmore Heights Holywood BT18 OPY Co Down | British | Computer Consultant | 143679280001 | |||||
SMITH, John Bolton | Geschäftsführer | 60 Ballyholme Road Bangor BT20 5LA | Northern Ireland | British | Consultant | 155675230001 | ||||
TAYLOR, Keith Wilhall | Geschäftsführer | Dove Cottage Sly Corner HP16 9LD Great Missenden Buckinghamshire | England | British | Company Director | 119095470001 | ||||
THOMPSON, Richard James | Geschäftsführer | 19f Airfields Drive Ravenshead NG15 9HR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Finance Director | 64550460002 | ||||
THOMPSON, Richard James | Geschäftsführer | 19 Fairfields Drive Ravenshead NG15 9HR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Finance Director | 64550460002 | ||||
WOODBRIDGE, Mark Gavin | Geschäftsführer | The Bungalow Marton CV8 9RS Rugby Warwickshire | British | Finance | 74738270002 |
Hat FIGURE RETAIL SYSTEMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Nov. 2004 Geliefert am 03. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies guarantee and debenture.. The company, as security for the payment, discharge and performance of all the secured liabilities charges to the security trustee:. 1.1 by way of a first legal mortgage the freehold and leasehold property set out in schedule 3 of the guarantee and debenture;. See 402 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 09. Aug. 2004 Geliefert am 18. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies deed of admission the further companies and the existing companies jointly and severally agree that the bank may combine or consolidate all or consolidate all or any of the accounts with any or all of the principal liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 16. Feb. 2004 Geliefert am 26. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies debenture deed the freehold and leasehold property of the company both present and future including the....... See doc 55 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 16. Feb. 2004 Geliefert am 26. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies an omnibus guarantee & set- off agreement any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the companies or any of them with the bank... See doc 54 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 24. Nov. 1999 Geliefert am 29. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 24. Nov. 1999 Geliefert am 29. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Floating charge the undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. The company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money otherwise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0