AP (NI) (NO.1) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AP (NI) (NO.1) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI024802 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AP (NI) (NO.1) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AP (NI) (NO.1) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Tughans Solicitors, Marlborough House 30 Victoria Street BT1 3GG Belfast Co Antrim |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AP (NI) (NO.1) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
E.A. BAIRD (N'ARDS) LIMITED | 06. Juli 1995 | 06. Juli 1995 |
WM. MARTIN (N'ARDS) LIMITED | 12. Sept. 1990 | 12. Sept. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AP (NI) (NO.1) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AP (NI) (NO.1) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher James Giles als Geschäftsführer am 05. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor am 05. Sept. 2011 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AP (NI) (NO.1) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSTER, David Charles Geoffrey | Sekretär | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | British | 150395280001 | ||||||
FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | Solicitor | 52040210004 | ||||
MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | Thane Road West NG2 3AA Nottingham 1 | United Kingdom | British | Director | 63620010002 | ||||
BAIRD, Irene Deirdre | Sekretär | 9,Rosepark East Belfast BT5 7RL | 144417380001 | |||||||
MULLER, Mark Francis, Mr. | Sekretär | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | British | 63620010002 | ||||||
AU COSEC LIMITED | Sekretär | Brooklands Weybridge KT13 0NY Surrey | 68799430002 | |||||||
AYLWARD, Christopher David | Geschäftsführer | Buchan Cottage 2 Cheapside GU21 4JG Horsell Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 59741430002 | ||||
BAIRD, Austin Richard | Geschäftsführer | 48 Circular Road Belmont BT4 2GB Belfast County Antrim | Northern Ireland | British | Pharmasist | 143001420001 | ||||
BAIRD, Catherine Jane | Geschäftsführer | 9 Rosepark East Belfast BT5 7RL | British | Company Director | 144417440001 | |||||
BAIRD, Ernest | Geschäftsführer | 9,Rosepark East Belfast BT5 7RL | British | Pharmacist | 144417390001 | |||||
BAIRD, Irene Deirdre | Geschäftsführer | 9 Rosepark East Dundonald BT5 7RL | British | Housewife | 144417410001 | |||||
CASEMENT, Diane Elizabeth | Geschäftsführer | 12 Middle Road Saintfield BT24 7LP | British | Pharmacist | 144417430001 | |||||
GILES, Christopher James | Geschäftsführer | 30 Victoria Street BT1 3GG Belfast C/O Tughans Solicitors, Marlborough House Co Antrim | England | British | Accountant | 150046230001 | ||||
HULME, Simon | Geschäftsführer | The West Wing Callaly Castle NE66 4TA Whittingham Alnwick | United Kingdom | British | Director | 105524430001 | ||||
JOHNSTON, Alison Mary Louise | Geschäftsführer | 12 Gowan Heights Dunmurry BT17 9LZ Belfast | British | Co. Director | 144417450001 | |||||
JOHNSTON, Colin James | Geschäftsführer | 12 Gowan Heights Drumbeg Road BT17 9LZ Drumbeg Belfast | Northern Ireland | British | Chartered Accountant | 144317390001 | ||||
MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 63620010002 | ||||
PROSSER, Andrew James Mackenzie | Geschäftsführer | Tamarind Camilla Drive RH5 6BU Westhumble Dorking | England | British | Director | 151240810001 |
Hat AP (NI) (NO.1) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage or charge | Erstellt am 31. Jan. 2005 Geliefert am 08. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage/charge. Premises situate at 42 and 44 holywood rad, belfast. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 23. Aug. 2004 Geliefert am 23. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage / charge all that the lands and premises situate at 56A rathmore road, carnalea, bangor, county down BT19 1WL...... See doc 64 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 18. März 2003 Geliefert am 20. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage and counterpart mortgage. All of the land comprised in folio no. Dn 104360 county down and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of the security become the property of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. Okt. 2002 Geliefert am 15. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. The premises at the square 2-4 fair green road marjethill county armagh the dispensing pharmaceutical licence....... ........................................ see doc 59 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 27. Sept. 2002 Geliefert am 02. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage the leasehold premises at units NO3 & 7 sailsbury square, queen street ballymena co antrim............................... See doc 60 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 13. Sept. 2002 Geliefert am 23. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. The premises situate at 97-107, high street, bangor, county down being the lands and premises more particularly described in deed of conveyance and assignment dated the 13TH day of september 2002 and made between stranmillis investments limited of the one part and the mortgagor of the other see doc 56 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 31. Juli 2002 Geliefert am 02. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. The leasehold premises at 72 holywood road, belfast, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Juli 2002 Geliefert am 02. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. The leasehold premises at 13 john mitchel place, newry, county down, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 01. Juli 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. The leasehold premises at 83, the promenade, portstewart, co londonderry, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery......................... See doc 53 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 31. Mai 2002 Geliefert am 07. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. All that and those lands situate at chapel hill, lisburn, county antrim as are comprised in deed of conveyance dated 31ST may 2002 and made between thomas hague and pauline hague of the one part and mortgagor of the other part. See doc 52 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. März 2002 Geliefert am 12. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Mortgage - all monies. The leasehold premises at 9, high street lurgan........ See doc. No. 51 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 01. Juli 2000 Geliefert am 06. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 80A main street, cullybackey, county antrim together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 05. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 324 beersbridge road, belfast together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 28. Nov. 1997 Geliefert am 02. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage. Premises situate and known as 17 and 19 hillsborough road, dromara, county down together with all fixed and moveable plant and machinery implements utensils furniture and equipment and together also with the dispensing pharmaceutical license. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 31. Juli 1996 Geliefert am 31. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Mortgage debenture see doc 31 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 23. Aug. 1995 Geliefert am 01. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Mortgage the premises situate and known as nos. 104, 106 and 108 frances street, newtownards. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 06. Juni 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies charge over all book debts.. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 06. Juni 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies floating charge.. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See 402 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0