THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformLimited Liability Partnership
    Unternehmensnummer OC300507
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis05. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Handelsregister

    2 SeitenLLDS01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Julian Worthington Botham als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Oliver Udell als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip Patrick Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Francis Winn als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Iestyn Milton Williams als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Bernard St John Webb als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Walter Henry Rupert Wilkes als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael James Walker als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen William Vaughan als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher John Wade als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Vallender als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Gibson Usher als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin Philip Trees als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Gary Gerard Toner als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Daniel Thompson als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Andrew Thorogood als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von David Allan Thorpe als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Michael Stevens als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Clifford Mark Sturt als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Tony Paul Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Jacqueline Stephens als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Anthony Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019

    1 SeitenLLTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Bestelltes Mitglied der LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Bestelltes Mitglied der LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4244204
    141180020001
    ADRIAN SMITH, Christine
    37 Peter Avenue
    RH8 9LG Oxted
    Mitglied der LLP
    37 Peter Avenue
    RH8 9LG Oxted
    United Kingdom141213220001
    ANDREW, Jonathan
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    Mitglied der LLP
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    England88713160003
    ANTHONY, Johanne
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    Mitglied der LLP
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    United Kingdom141213460001
    ANTHONY, Nigel Richard Dalton
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    Mitglied der LLP
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    United Kingdom111623810002
    BAIRD, Robert George
    44 Elms Road
    SW4 9EX London
    Mitglied der LLP
    44 Elms Road
    SW4 9EX London
    United Kingdom32823440001
    BAKER, Martin Keith
    15 Dault Road
    Wandsworth
    SW18 2NH London
    Mitglied der LLP
    15 Dault Road
    Wandsworth
    SW18 2NH London
    United Kingdom116071820001
    BAKER, Richard Andrew
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Mitglied der LLP
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    United Kingdom290972040001
    BARNES, Andrew Seton
    1 Upper Cheyne Row
    SW3 5JW London
    The Cottage
    Mitglied der LLP
    1 Upper Cheyne Row
    SW3 5JW London
    The Cottage
    United Kingdom119126870001
    BEDFORD, Lindsay Paul
    York Road
    RG1 8DX Reading
    54
    Berkshire
    Mitglied der LLP
    York Road
    RG1 8DX Reading
    54
    Berkshire
    United Kingdom141223660002
    BENNETT, Michael Andrew
    32 Burwood Park Road
    KT12 5LH Walton On Thames
    Mitglied der LLP
    32 Burwood Park Road
    KT12 5LH Walton On Thames
    United Kingdom56285510001
    BEST, Anthony John
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    Mitglied der LLP
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    United Kingdom141213930001
    BISHOP, Robert
    The Coach House
    4 Manor House Drive
    ME16 8AJ Maidstone
    Mitglied der LLP
    The Coach House
    4 Manor House Drive
    ME16 8AJ Maidstone
    United Kingdom141213240004
    BOLAND, Stanley
    Litchfield House
    Finch Lane Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Mitglied der LLP
    Litchfield House
    Finch Lane Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    United Kingdom141223680001
    BOTHAM, Trevor Julian Worthington
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    Mitglied der LLP
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    United Kingdom141223590001
    BRERETON, Michael Philip
    3 Pondwicks Close
    AL1 1DG St Albans
    Mitglied der LLP
    3 Pondwicks Close
    AL1 1DG St Albans
    141213610001
    BRIGDEN, Steve John
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    Mitglied der LLP
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    United Kingdom141213650001
    BROWN, Michael Ross
    1 Ayres End Cottages
    Ayres End Lane
    AL5 1AL Harpenden
    Mitglied der LLP
    1 Ayres End Cottages
    Ayres End Lane
    AL5 1AL Harpenden
    United Kingdom66293640001
    BRYANT, Clive
    3 Chapel Close
    NN12 8HZ Litchborough
    Mitglied der LLP
    3 Chapel Close
    NN12 8HZ Litchborough
    United Kingdom141213540001
    CAKEBREAD, Stuart Alan Charles
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    Mitglied der LLP
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    United Kingdom141213960001
    CAMPBELL, Colin William Roderick
    44 Kingfield Road
    S11 9AS Sheffield
    Mitglied der LLP
    44 Kingfield Road
    S11 9AS Sheffield
    United Kingdom141223650001
    CAMRASS, Roger Jeremy
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    Mitglied der LLP
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    England45860180002
    CHALK, John William
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    Mitglied der LLP
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    United Kingdom74739180015
    CHALK, Peter Henry
    Hopdene Court
    Holmbury St Mary
    RH5 6PE Dorking
    Mitglied der LLP
    Hopdene Court
    Holmbury St Mary
    RH5 6PE Dorking
    United Kingdom141213880001
    COURTLEY, David John
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    Mitglied der LLP
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    England141213480001
    CRAWFORD, Philip James
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    Mitglied der LLP
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    England61146460001
    CREAGER, David Howard
    25 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    Mitglied der LLP
    25 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    United Kingdom119102510001
    CUSSINS, Peter Ian
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    Mitglied der LLP
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom68297000001
    DENHAM, Andrew Victor
    Manor Farm Cottage
    Tunworth Road
    RG25 0LU Mapledurwell
    Mitglied der LLP
    Manor Farm Cottage
    Tunworth Road
    RG25 0LU Mapledurwell
    England141213640001
    DOOTSON, David Philip
    158 Manchester Road
    SK9 2JW Wilmslow
    Mitglied der LLP
    158 Manchester Road
    SK9 2JW Wilmslow
    United Kingdom181912770001
    DUERDEN, John Henry
    1 Elwell Avenue
    HU17 8HJ Beverley
    Mitglied der LLP
    1 Elwell Avenue
    HU17 8HJ Beverley
    United Kingdom13822610002
    DYSON, Fernley Keith
    Oak House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Mitglied der LLP
    Oak House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    63727860003
    EYRE, Raymond Charles
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    Mitglied der LLP
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    England44367560006
    FEAST, Alan George
    49 Chillerton Road
    SW17 9BE London
    Mitglied der LLP
    49 Chillerton Road
    SW17 9BE London
    England141213940001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    26. Sept. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over assets
    Erstellt am 01. Aug. 2002
    Geliefert am 05. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sociiti Ginirale
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 02. Mai 2002
    Geliefert am 03. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 03. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 02. Mai 2002
    Geliefert am 03. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 03. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 17. Apr. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 16. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same and the debts represented thereby including all interest (if any) any proceeds all causes of action assigns all rights title and interest in and to all present and future minimum revenue entitlement all guarantees all moneys due and payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Pledge and charge
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (1) charged (subject only to the rights and interest of parties to the prior agreements and the transcation documents and as otherwise provided in the pledge and charge), all the chargor's right, title and interest in the assigned rights and the licensed rights, and (2) pledged the delivery material to the chargee.
    Berechtigte Personen
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners, Alvarengainvestments B.V. and Herfsttafel Incestments B.V.
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 05. Apr. 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all right,title and interest in and to all moneys standing to the credit of each dedicated account and the debts represented thereby with all interest owing and any proceeds thereof; all minimum revenue entitlement,guarantees,letters of credit,deposits or other security. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (London Branch)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 03. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (London Branch)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over assets
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 03. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (London Branch)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Pledge and charge
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 26. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The delivery material. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners Alvarenga Investments B.V.and Herfsttafel Investments B.V.
    Transaktionen
    • 26. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Pledge and charge
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 26. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Pledged and the delivery materials to the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners Alvarenga Investments B.V.and Herfsttafel Investments B.V.
    Transaktionen
    • 26. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (LLMR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0