THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP
Überblick
| Unternehmensname | THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Limited Liability Partnership |
| Unternehmensnummer | OC300507 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Handelsregister | 2 Seiten | LLDS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Trevor Julian Worthington Botham als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Oliver Udell als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Patrick Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Francis Winn als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Iestyn Milton Williams als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Bernard St John Webb als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Walter Henry Rupert Wilkes als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael James Walker als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen William Vaughan als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Wade als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Christopher Vallender als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Gibson Usher als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Martin Philip Trees als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gary Gerard Toner als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Daniel Thompson als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Andrew Thorogood als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Allan Thorpe als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Michael Stevens als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Clifford Mark Sturt als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Tony Paul Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Stephens als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Anthony Smith als Mitglied am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVICTA FILM NOMINEES LIMITED | Bestelltes Mitglied der LLP | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow |
| 141180010001 | ||||||||||
| SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED | Bestelltes Mitglied der LLP | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow |
| 141180020001 | ||||||||||
| ADRIAN SMITH, Christine | Mitglied der LLP | 37 Peter Avenue RH8 9LG Oxted | United Kingdom | 141213220001 | ||||||||||
| ANDREW, Jonathan | Mitglied der LLP | Steels Lane Cherington CV36 5HL Shipston On Stour The Thatched Cottage Warwickshire | England | 88713160003 | ||||||||||
| ANTHONY, Johanne | Mitglied der LLP | Pear Tree Cottage Church Way Ecton NN6 0QE Northampton | United Kingdom | 141213460001 | ||||||||||
| ANTHONY, Nigel Richard Dalton | Mitglied der LLP | Pear Tree Cottage Church Way Ecton NN6 0QE Northampton | United Kingdom | 111623810002 | ||||||||||
| BAIRD, Robert George | Mitglied der LLP | 44 Elms Road SW4 9EX London | United Kingdom | 32823440001 | ||||||||||
| BAKER, Martin Keith | Mitglied der LLP | 15 Dault Road Wandsworth SW18 2NH London | United Kingdom | 116071820001 | ||||||||||
| BAKER, Richard Andrew | Mitglied der LLP | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | United Kingdom | 290972040001 | ||||||||||
| BARNES, Andrew Seton | Mitglied der LLP | 1 Upper Cheyne Row SW3 5JW London The Cottage | United Kingdom | 119126870001 | ||||||||||
| BEDFORD, Lindsay Paul | Mitglied der LLP | York Road RG1 8DX Reading 54 Berkshire | United Kingdom | 141223660002 | ||||||||||
| BENNETT, Michael Andrew | Mitglied der LLP | 32 Burwood Park Road KT12 5LH Walton On Thames | United Kingdom | 56285510001 | ||||||||||
| BEST, Anthony John | Mitglied der LLP | 64 Chester Square SW1W 9EA London | United Kingdom | 141213930001 | ||||||||||
| BISHOP, Robert | Mitglied der LLP | The Coach House 4 Manor House Drive ME16 8AJ Maidstone | United Kingdom | 141213240004 | ||||||||||
| BOLAND, Stanley | Mitglied der LLP | Litchfield House Finch Lane Knotty Green HP9 2TL Beaconsfield | United Kingdom | 141223680001 | ||||||||||
| BOTHAM, Trevor Julian Worthington | Mitglied der LLP | 10 Vanbrugh Fields SE3 7TZ London | United Kingdom | 141223590001 | ||||||||||
| BRERETON, Michael Philip | Mitglied der LLP | 3 Pondwicks Close AL1 1DG St Albans | 141213610001 | |||||||||||
| BRIGDEN, Steve John | Mitglied der LLP | 60 Crown Road OX33 1UL Wheatley | United Kingdom | 141213650001 | ||||||||||
| BROWN, Michael Ross | Mitglied der LLP | 1 Ayres End Cottages Ayres End Lane AL5 1AL Harpenden | United Kingdom | 66293640001 | ||||||||||
| BRYANT, Clive | Mitglied der LLP | 3 Chapel Close NN12 8HZ Litchborough | United Kingdom | 141213540001 | ||||||||||
| CAKEBREAD, Stuart Alan Charles | Mitglied der LLP | Manor Cottage The Green OX12 0LQ West Hanney | United Kingdom | 141213960001 | ||||||||||
| CAMPBELL, Colin William Roderick | Mitglied der LLP | 44 Kingfield Road S11 9AS Sheffield | United Kingdom | 141223650001 | ||||||||||
| CAMRASS, Roger Jeremy | Mitglied der LLP | 34 Stormont Road N6 4NP London | England | 45860180002 | ||||||||||
| CHALK, John William | Mitglied der LLP | Flat 1501 20 Palace Street SW1E 5BB London | United Kingdom | 74739180015 | ||||||||||
| CHALK, Peter Henry | Mitglied der LLP | Hopdene Court Holmbury St Mary RH5 6PE Dorking | United Kingdom | 141213880001 | ||||||||||
| COURTLEY, David John | Mitglied der LLP | 25 Mount Pleasant Villas Crouch End N4 4HH London | England | 141213480001 | ||||||||||
| CRAWFORD, Philip James | Mitglied der LLP | Cranbourne Lodge Drift Road SL4 4RP Winkfield | England | 61146460001 | ||||||||||
| CREAGER, David Howard | Mitglied der LLP | 25 Tretawn Park Mill Hill NW7 4PS London | United Kingdom | 119102510001 | ||||||||||
| CUSSINS, Peter Ian | Mitglied der LLP | Bitchfield Tower Belsay NE20 0JP Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | 68297000001 | ||||||||||
| DENHAM, Andrew Victor | Mitglied der LLP | Manor Farm Cottage Tunworth Road RG25 0LU Mapledurwell | England | 141213640001 | ||||||||||
| DOOTSON, David Philip | Mitglied der LLP | 158 Manchester Road SK9 2JW Wilmslow | United Kingdom | 181912770001 | ||||||||||
| DUERDEN, John Henry | Mitglied der LLP | 1 Elwell Avenue HU17 8HJ Beverley | United Kingdom | 13822610002 | ||||||||||
| DYSON, Fernley Keith | Mitglied der LLP | Oak House Broom Way KT13 9TG Weybridge | 63727860003 | |||||||||||
| EYRE, Raymond Charles | Mitglied der LLP | 79 Addison Road Holland Park W14 8ED London | England | 44367560006 | ||||||||||
| FEAST, Alan George | Mitglied der LLP | 49 Chillerton Road SW17 9BE London | England | 141213940001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 26. Sept. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over assets | Erstellt am 01. Aug. 2002 Geliefert am 05. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 02. Mai 2002 Geliefert am 03. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 02. Mai 2002 Geliefert am 03. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 17. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 16. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same and the debts represented thereby including all interest (if any) any proceeds all causes of action assigns all rights title and interest in and to all present and future minimum revenue entitlement all guarantees all moneys due and payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge and charge | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 15. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (1) charged (subject only to the rights and interest of parties to the prior agreements and the transcation documents and as otherwise provided in the pledge and charge), all the chargor's right, title and interest in the assigned rights and the licensed rights, and (2) pledged the delivery material to the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 12. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge over all right,title and interest in and to all moneys standing to the credit of each dedicated account and the debts represented thereby with all interest owing and any proceeds thereof; all minimum revenue entitlement,guarantees,letters of credit,deposits or other security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 03. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over assets | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 03. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge and charge | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 26. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The delivery material. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge and charge | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 26. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Pledged and the delivery materials to the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0