CATALYST QUARTET LLP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCATALYST QUARTET LLP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformLimited Liability Partnership
    Unternehmensnummer OC304862
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich CATALYST QUARTET LLP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CATALYST QUARTET LLP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für CATALYST QUARTET LLP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    18 Seiten4.71

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2016

    10 SeitenLLAR01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Nov. 2015

    15 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Entscheidung

    1 SeitenDETERMINAT

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015

    10 SeitenLLAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Peter Carwile Kasch als Mitglied am 23. Okt. 2014

    1 SeitenLLTM01

    Ernennung von Mr Peter Carwile Kasch als Mitglied am 23. Okt. 2014

    2 SeitenLLAP01

    Hinweis auf Statusänderung

    2 SeitenLLDE01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014

    10 SeitenLLAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2013

    10 SeitenLLAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2012

    10 SeitenLLAR01

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Cataylst Capital Llp am 13. Juni 2012

    1 SeitenLLCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2011

    10 SeitenLLAR01

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Cataylst Capital Llp am 13. Juni 2011

    2 SeitenLLCH02

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2010

    19 SeitenLLAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 11Th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW* am 10. März 2010

    1 SeitenLLAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CATALYST QUARTET LLP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DE CLERMONT TONNERRE, Fabrice Tillette
    1 Rue Des Verdy
    92310 Sevres
    France
    Bestelltes Mitglied der LLP
    1 Rue Des Verdy
    92310 Sevres
    France
    France142598030002
    LEE, Charles Mackenzie
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Nr Amersham
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Nr Amersham
    England88355580001
    NEWISS, Julian Ralph Stewart
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    England25776880001
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    England141163370001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    United Kingdom141163390001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    High Street
    OX14 4NA Culham Nr Abingdon
    Culham House
    Oxfordshire
    Bestelltes Mitglied der LLP
    High Street
    OX14 4NA Culham Nr Abingdon
    Culham House
    Oxfordshire
    England141163410001
    YIANNAKIS, Anthony Constantine
    The Grange
    Eyhurst Close Kingswood
    KT20 6NR Tadworth
    Bestelltes Mitglied der LLP
    The Grange
    Eyhurst Close Kingswood
    KT20 6NR Tadworth
    United Kingdom141163380001
    CATAYLST CAPITAL LLP
    Floor
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    18th
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Floor
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    18th
    RechtsformUK
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageUK
    RegistrierungsnummerOC300021
    141355560001
    KASCH, Peter Carwile
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    Mitglied der LLP
    Cavendish Square
    W1G 0PW London
    33
    England192050620001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    United Kingdom61386600003
    PETTIT, Stephen
    77 Ronalds Road
    N5 1XB London
    Bestelltes Mitglied der LLP
    77 Ronalds Road
    N5 1XB London
    141355530001

    Hat CATALYST QUARTET LLP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2004
    Geliefert am 08. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h land with t/no WM797297 being 123, 125 and 127 hagley road edgebaston. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 7 april 2004 dated 30 march 2004 and
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a 15 john street penicuik t/n MID19204.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold land at st matthews house shepherdess walk london t/n EGL323125. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 july 2003 dated 3RD july 2003 and
    Erstellt am 04. Juli 2003
    Geliefert am 19. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the south side of ashley road southfield industrial estate glenrothes t/n FFE13137.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 30 june 2003 and
    Erstellt am 04. Juli 2003
    Geliefert am 17. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in the lease of property k/a penicuik shopping centre, ancillary land and 11/13 john street penicuik t/no MID43410.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 27 june 2003 and
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 11. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The interest in the lease pending registration under t/no MID43390 of property at 1 to 21 kittleyards causewayside edinburgh and 201 causewaywide edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 27 june 2003 and
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 11. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The subjects k/a and forming 24/26 torphichen street and 2/4 dewar place lane edinburgh county of midlothian.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 27 june 2003 and
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 11. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The interest in the lease currently being registered with t/no MID43393 of property at 2 bankhead drive sighthill edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 27 june 2003 and
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 11. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The interest in the lease pending registration with t/no ANG26866 of property at riverside house and riverside distribution centre dundee.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 123, 125 and 127 hagley road, birmingham let under a lease dated 30 june 2003 and made between dunedin property ventures limited (1) and quartet portfolio limited, catalyst quartet LLP and catalyst quartet wigmore limited (2). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's interest in the agreement being an agreement for sale dated 30 june 2003 and the charged property being the f/h property k/a st mathew's house, shepherdess walk, london t/no. EGL232125. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 30 june 2003 and
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in a lease of property k/a anderston house 389 argyle street glasgow t/no gla 169586.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 30 june 2003 and
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in the lease in relation to the property k/a cumbernauld shopping park st mungo's road cumbernauld t/no DMB73355.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 4 july 2003 dated 30 june 2003 and
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the quartet partnership to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest under a sub-lease of the property k/a the regent centre cowgate kirkintilloch t/no DMB73353.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CATALYST QUARTET LLP Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. März 2017Aufgelöst am
    04. Nov. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kate E Breese
    Oxford Chambers Oxford Road
    Guiseley
    LS20 9AT Leeds
    Praktiker
    Oxford Chambers Oxford Road
    Guiseley
    LS20 9AT Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0