REPTON FILM PARTNERSHIP LLP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREPTON FILM PARTNERSHIP LLP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformLimited Liability Partnership
    Unternehmensnummer OC308650
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis05. Apr. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 05. Apr. 2021

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Robert Darren Withecombe als Mitglied am 05. März 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Manish Suchak als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Jonathan Wiles als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von John William Richards als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Grant Giles als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Patrick James Stead als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von David John Farrer als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Andrew Bradley als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Granville Atherton als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Emanuel Meyr Arbib als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Francoise Ellen Atherton als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Paul Martin Abel als Mitglied am 05. Apr. 2021

    1 SeitenLLTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 05. Apr. 2020

    3 SeitenAA

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Navigational Capital, Inc. am 13. Sept. 2019

    2 SeitenLLCH02

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juli 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenLLCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 05. Apr. 2019

    3 SeitenAA

    Notification of Graham Bradstreet as a person with significant control on 20. Apr. 2018

    2 SeitenLLPSC01

    Widerruf einer Erklärung einer Person mit maßgeblichem Einfluss am 04. Okt. 2019

    2 SeitenLLPSC09

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenLLCS01

    Beendigung der Bestellung von Panosh Limited als Mitglied am 26. Juli 2019

    1 SeitenLLTM01

    Ernennung von Navigational Capital, Inc. als Mitglied am 24. Apr. 2019

    2 SeitenLLAP02

    Ernennung von Irelandonscreenlive Limited als Mitglied am 17. Juni 2019

    2 SeitenLLAP02

    Wer sind die Geschäftsführer von REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    IRELANDONSCREENLIVE LIMITED
    The Avenue Woodpark
    Ballinteer
    Dublin 16 D16xa97
    11
    Ireland
    Bestelltes Mitglied der LLP
    The Avenue Woodpark
    Ballinteer
    Dublin 16 D16xa97
    11
    Ireland
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    Registrierungsnummer546430
    191961360001
    THROWA LIMITED
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    Registrierungsnummer526288
    178741040002
    BCNL HOLDINGS INC.
    c/o G Bradstreet
    Leghorn Ave
    Sherman Oaks
    5343
    Ca 91401
    United States
    Mitglied der LLP
    c/o G Bradstreet
    Leghorn Ave
    Sherman Oaks
    5343
    Ca 91401
    United States
    RechtsformLIMITED COMPANY
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    RechtsgrundlageWYOMING, USA
    Registrierungsnummer2018-000799693
    260901110002
    CRANNOG FILMS LIMITED
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer280953
    178740570001
    SCOTTS NOMINEES LIMITED
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Bestelltes Mitglied der LLP
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC224914
    142626690001
    SCOTTS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Bestelltes Mitglied der LLP
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC224913
    147831700001
    ABEL, Richard Paul Martin
    High Trees, Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SA Bristol
    Mitglied der LLP
    High Trees, Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SA Bristol
    United Kingdom141651130001
    ANVARZADEH, Amir Shahriar
    Aston Residence
    209 Jalan Loyang Besar
    Singapore
    01-09
    509489
    Singpore
    Mitglied der LLP
    Aston Residence
    209 Jalan Loyang Besar
    Singapore
    01-09
    509489
    Singpore
    Singapore147506880003
    ARBIB, Emanuel Meyr
    9 Ashworth Road
    W9 1JW London
    Mitglied der LLP
    9 Ashworth Road
    W9 1JW London
    United Kingdom58363040004
    ARORA, Surinder
    8 Hush Willows
    Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    Mitglied der LLP
    8 Hush Willows
    Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    United Kingdom70271560007
    ATHERTON, Francoise Ellen
    Trewatha
    Oxford Lodge
    MK18 5DA Stowe
    Mitglied der LLP
    Trewatha
    Oxford Lodge
    MK18 5DA Stowe
    United Kingdom141310390001
    ATHERTON, Peter Granville, Dr
    Oxford Lodge
    Stowe
    MK18 5DA Buckingham
    Trewetha
    Mitglied der LLP
    Oxford Lodge
    Stowe
    MK18 5DA Buckingham
    Trewetha
    England106838980004
    BEANEY, Gerald Douglas
    Grant Thornton
    Melton Street Euston Square
    NW1 2EP London
    Mitglied der LLP
    Grant Thornton
    Melton Street Euston Square
    NW1 2EP London
    United Kingdom141507230002
    BRADLEY, Michael Andrew
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    Mitglied der LLP
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    United Kingdom141634070001
    BROWNE, David Scott
    Flat 11, Transcend
    110 St. Leonards Road
    SL4 3BJ Windsor
    Mitglied der LLP
    Flat 11, Transcend
    110 St. Leonards Road
    SL4 3BJ Windsor
    United Kingdom141651160001
    CRANE, Robert
    79 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Mitglied der LLP
    79 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    United Kingdom141651170001
    DRUTTMAN, George Adam Robert
    10 Tadmor Street
    W12 8AH London
    Mitglied der LLP
    10 Tadmor Street
    W12 8AH London
    England141227030001
    DYSON, Toni Adele
    45 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Mitglied der LLP
    45 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    England141582750001
    FABIAN, Shaun Barry
    12 The Avenue
    BN5 4EN Barnet
    Mitglied der LLP
    12 The Avenue
    BN5 4EN Barnet
    United Kingdom78654200003
    FARRER, David John
    The Grange
    50 Main Street Hoby
    LE14 3DT Melton Mowbray
    Mitglied der LLP
    The Grange
    50 Main Street Hoby
    LE14 3DT Melton Mowbray
    United Kingdom141651200001
    GILES, Timothy Grant
    Ivy Lodge
    Badby Road
    NN11 3HE Newnham
    Mitglied der LLP
    Ivy Lodge
    Badby Road
    NN11 3HE Newnham
    United Kingdom141651230001
    GREGORY, Andrew
    4 Great Molewood
    SG14 2PN Hertford
    Mitglied der LLP
    4 Great Molewood
    SG14 2PN Hertford
    United Kingdom141651240001
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Mitglied der LLP
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    United Kingdom48297190002
    HUTCHINSON, Graeme
    16 Shute End
    RG40 1BJ Wokingham
    Hulbert Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    Mitglied der LLP
    16 Shute End
    RG40 1BJ Wokingham
    Hulbert Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    United Kingdom141651210002
    JARMAN, Trevor Rodney, Dr
    18 Moss Drive
    Haslingfield
    CB3 7JB Cambridge
    Mitglied der LLP
    18 Moss Drive
    Haslingfield
    CB3 7JB Cambridge
    England20267110001
    KLEIN, Elizabeth
    Highfield Mews, Compayne Gardens
    NW6 3GB London
    11
    Mitglied der LLP
    Highfield Mews, Compayne Gardens
    NW6 3GB London
    11
    141651270002
    LEWIS, Martin Allen
    11 The Ridgeway
    WD7 8PZ Radlett
    Mitglied der LLP
    11 The Ridgeway
    WD7 8PZ Radlett
    England141582740001
    MAGGS, Douglas John
    Rosebury Court
    15 Charles Street
    W1J 5EX London
    Flat 7
    Mitglied der LLP
    Rosebury Court
    15 Charles Street
    W1J 5EX London
    Flat 7
    England78798720002
    MCANDIE, Stewart Cameron
    81 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RW London
    Mitglied der LLP
    81 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RW London
    United Kingdom141442150001
    MCKENCHNIE, Timothy James
    Broadway Road
    GU20 6DA Windlesham
    Springhill
    Surrey
    United Kingdom
    Mitglied der LLP
    Broadway Road
    GU20 6DA Windlesham
    Springhill
    Surrey
    United Kingdom
    United Kingdom141651280002
    PARKINSON, Noel David
    Station Road
    South Cave
    EU15 2AG Brough
    Drewton Farm
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Mitglied der LLP
    Station Road
    South Cave
    EU15 2AG Brough
    Drewton Farm
    East Yorkshire
    United Kingdom
    England141649670002
    PEPPER, Andrew John
    Little Frenchs Farm House
    Snow Hill
    RH10 3EG Crawley
    Mitglied der LLP
    Little Frenchs Farm House
    Snow Hill
    RH10 3EG Crawley
    England153926200001
    PRICE, Mark
    Copt Hill
    Danbury
    CM3 4NW Chelmsford
    Dane Court
    United Kingdom
    Mitglied der LLP
    Copt Hill
    Danbury
    CM3 4NW Chelmsford
    Dane Court
    United Kingdom
    United Kingdom117299680002
    RICHARDS, John William
    Le Millefiori
    1 Rue De Genets
    Mc98000
    11b
    Monaco
    Monaco
    Mitglied der LLP
    Le Millefiori
    1 Rue De Genets
    Mc98000
    11b
    Monaco
    Monaco
    Monaco141640370004
    ROTTGEN, Raphael
    29a Neal Street
    WC2H 9PR London
    Mitglied der LLP
    29a Neal Street
    WC2H 9PR London
    United Kingdom141633620001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Graham Bradstreet
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    20. Apr. 2018
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    Nein
    Nationalität: New Zealander
    Staatsangehörigkeit: United States
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält unmittelbar oder mittelbar mehr als 50 %, jedoch nicht mehr als 75 % der Stimmrechte an der LLP.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für REPTON FILM PARTNERSHIP LLP?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    15. Juli 201620. Apr. 2018Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat REPTON FILM PARTNERSHIP LLP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over assets
    Erstellt am 16. Jan. 2013
    Geliefert am 30. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "mine ha ha" see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    Charge over assets
    Erstellt am 16. Jan. 2013
    Geliefert am 30. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "fire" see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    Charge over assets
    Erstellt am 16. Jan. 2013
    Geliefert am 30. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "volcano" see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    Charge over assets
    Erstellt am 16. Jan. 2013
    Geliefert am 30. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "tempesta" see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    A charge over assets relating to the film "nature unleashed - volcano"
    Erstellt am 08. Sept. 2005
    Geliefert am 14. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account together with any proceeds tehreof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A charge over assets
    Erstellt am 04. Aug. 2005
    Geliefert am 12. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account together with any proceeds tehreof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over assets
    Erstellt am 04. Aug. 2005
    Geliefert am 12. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge all its right title benefit and interest all secured liabilities all moneys any proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over assets
    Erstellt am 09. Juni 2005
    Geliefert am 17. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title benefit and interest in and to all money from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof assigns all present and future minimal rental payments the guarantee any and all substitute bank guarantees floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over assets
    Erstellt am 12. Mai 2005
    Geliefert am 20. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The dedicated account, minimum rental payments, the guarantee and all substitute bank guarantees floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0