NW INDUSTRIAL LLP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNW INDUSTRIAL LLP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformLimited Liability Partnership
    Unternehmensnummer OC310347
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich NW INDUSTRIAL LLP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NW INDUSTRIAL LLP?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AMERDALE KILMARTIN LLP14. Juli 200514. Juli 2005
    AMERDALE INVESTMENTS LLP03. Dez. 200403. Dez. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NW INDUSTRIAL LLP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für NW INDUSTRIAL LLP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Handelsregister

    3 SeitenLLDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012

    8 SeitenLLAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2011

    3 SeitenLLAR01

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Kilmartin Property Group Limited am 03. Dez. 2011

    2 SeitenLLCH02

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Kilmartin Holdings Limited am 03. Dez. 2011

    2 SeitenLLCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    Rücktritt eines Auditors

    2 SeitenLLPAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010

    8 SeitenLLAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Amerdale Hopuse Broughton Hall Skipton North Yorkshire BD23 3AE am 02. Nov. 2010

    2 SeitenLLAD01

    Ernennung von Kilmartin Holdings Limited als Mitglied

    3 SeitenLLAP02

    Beendigung der Bestellung von Mark Hancock als Mitglied

    2 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von David Hood als Mitglied

    2 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Adam Kerr als Mitglied

    2 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Ridehalgh als Mitglied

    2 SeitenLLTM01

    Hinweis auf Namensänderung

    SeitenLLNM01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed amerdale kilmartin LLP\certificate issued on 16/04/10
    2 SeitenCERTNM

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2009

    9 SeitenLLAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom North Barn, Broughton Hall Broughton, Skipton North Yorkshire BD23 3AE am 19. Jan. 2010

    1 SeitenLLAD01

    Änderung der Angaben des Mitglieds für Adam Charles Kerr am 30. März 2006

    1 SeitenLLCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    16 SeitenAA

    legacy

    4 SeitenLLP363

    Wer sind die Geschäftsführer von NW INDUSTRIAL LLP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KILMARTIN HOLDINGS LIMITED (IN RECEIVERSHIP)
    2nd Floor 68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Bestelltes Mitglied der LLP
    2nd Floor 68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC149650
    153831270002
    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED (IN RECEIVERSHIP)
    2nd Floor
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Bestelltes Mitglied der LLP
    2nd Floor
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC158115
    141723240002
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    Bestelltes Mitglied der LLP
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    England141515870001
    HOOD, David Richard
    Throstles Nest Farm
    Conistone With Kilnsey
    BD23 5HT Skipton
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Throstles Nest Farm
    Conistone With Kilnsey
    BD23 5HT Skipton
    United Kingdom141372640001
    KERR, Adam Charles
    Snail Hall
    Millwood Road Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Snail Hall
    Millwood Road Polstead
    CO6 5AU Colchester
    United Kingdom141326000001
    RIDEHALGH, Jonathan Mark
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Mitglied der LLP
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    United Kingdom76321080001

    Hat NW INDUSTRIAL LLP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The net rental income and the benefit of all other rights and claims in relation to the properties,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 27. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a normanby park steelworks park farm road scunthorpe t/no HS112548, part of the f/h land lying to the west of park farm road scunthorpe t/no HS135826, part f/h land lying to the east and west of park farm road scunthorpe t/no HS129294 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 14. Dez. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Kurze Angaben
    The net rental income and benefit of all other rights and claims in relation to the property and all its right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land and buildings on the east side of orrell lane and netherton way bootle known as trinity park t/no MS278682. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 03. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment the net rental income and the benefit of all other rights and claims, by way of assignment the deposit and all right title and interets in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 2005
    Geliefert am 11. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the east side of orrell lane and netherton way bootle k/a trinity park t/no MS278682. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2005
    Geliefert am 03. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property being moorgate point moorgate road knowsley industrial park (north) kirkby merseyside by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill by way of floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment and charge
    Erstellt am 31. Jan. 2005
    Geliefert am 03. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of assignment the net rental income and the benefit to the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 2005
    Geliefert am 03. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0