OMNI FILMS 3 LLP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOMNI FILMS 3 LLP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformLimited Liability Partnership
    Unternehmensnummer OC346028
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich OMNI FILMS 3 LLP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1/1a Bakery Court London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OMNI FILMS 3 LLP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für OMNI FILMS 3 LLP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Handelsregister

    3 SeitenLLDS01

    Beendigung der Bestellung von Suber Pcs Llp als Mitglied am 30. Juni 2016

    1 SeitenLLTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2016

    3 SeitenLLAR01

    Beendigung der Bestellung von John Anthony Sharp als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von William James Wright als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von David Yates als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Sean Russell Williams als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Edward Wood als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Wheatley als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Charles Wheeler als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Martyn Elwyn Williams als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Bernard St John Webb als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Matthew John Webb als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Craig Alyn Watkins als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Horace Walton als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Douglas Turkington als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Catherine Jane Thorn als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Charles Taylor als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham John Tate als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Philip Stevens als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Brooke Marcus Stephens als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von John Justin Smith als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Simon Royle als Mitglied am 30. Dez. 2015

    1 SeitenLLTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von OMNI FILMS 3 LLP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRESCIENCE FILM FINANCE LIMITED
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Bestelltes Mitglied der LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04885246
    142484570001
    SUBER PCS LLP
    Ashby Road
    NN12 6PG Towcester
    30 Ashby Road
    Northamptonshire
    England
    Bestelltes Mitglied der LLP
    Ashby Road
    NN12 6PG Towcester
    30 Ashby Road
    Northamptonshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerOC306872
    142484580003
    ALLUM, Jonathon Edward
    Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    114
    Kent
    Mitglied der LLP
    Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    114
    Kent
    United Kingdom142173840001
    ARIYARAJNAM, Shyamala, Dr
    Talbenny Close
    BL1 5FG Bolton
    5
    Lancashire
    Mitglied der LLP
    Talbenny Close
    BL1 5FG Bolton
    5
    Lancashire
    Uk150575000001
    ARIYARATNAM, Rajkumar, Dr
    Talbenny Close
    BL1 5FG Bolton
    5
    Lancashire
    Mitglied der LLP
    Talbenny Close
    BL1 5FG Bolton
    5
    Lancashire
    United Kingdom150574890001
    ATKINSON, Anthony
    Randall Road
    Chandler's Ford
    SO53 5AJ Eastleigh
    37
    Hampshire
    Mitglied der LLP
    Randall Road
    Chandler's Ford
    SO53 5AJ Eastleigh
    37
    Hampshire
    United Kingdom142063890001
    BERTELSEN, Ole Peder
    Brantridge Lane
    Balcombe
    RH17 6JP Haywards Heath
    White House
    Mitglied der LLP
    Brantridge Lane
    Balcombe
    RH17 6JP Haywards Heath
    White House
    United Kingdom48699340001
    BITHREY, Paul Michael
    Lighthorne Rise
    LU3 3XG Luton
    8
    Bedfordshire
    Mitglied der LLP
    Lighthorne Rise
    LU3 3XG Luton
    8
    Bedfordshire
    England128951840001
    BOARDWELL, Trevor
    Skipton Old Road
    BB8 7AE Colne
    Greystones
    Lancashire
    Mitglied der LLP
    Skipton Old Road
    BB8 7AE Colne
    Greystones
    Lancashire
    England16987740001
    BROWELL, David
    Anick
    NE46 4LW Hexham
    Anick Old House
    Northumberland
    United Kingdom
    Mitglied der LLP
    Anick
    NE46 4LW Hexham
    Anick Old House
    Northumberland
    United Kingdom
    United Kingdom142227360002
    BUTTERFIELD, Geoffrey Robert
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Mitglied der LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    England150733400001
    CHITIRAMOHAN, Ramalingam Nirmalakumar, Dr
    Hamilton Avenue
    B17 8AR Birmingham
    60
    West Midlands
    Mitglied der LLP
    Hamilton Avenue
    B17 8AR Birmingham
    60
    West Midlands
    Britain149771680001
    CLOUGH, Stephen John
    East Downs Road
    WA14 2LQ Bowden
    Cransley
    Mitglied der LLP
    East Downs Road
    WA14 2LQ Bowden
    Cransley
    United Kingdom158703520001
    COOPER, Benjamin Joseph
    Circle Hill Road
    RG45 6RN Crowthorne
    Granville
    Mitglied der LLP
    Circle Hill Road
    RG45 6RN Crowthorne
    Granville
    Uk142802650001
    CORCORAN, Christopher
    Upperton
    Brightwell Baldwin
    OX49 5NY Watlington
    Acre View
    Oxon
    Mitglied der LLP
    Upperton
    Brightwell Baldwin
    OX49 5NY Watlington
    Acre View
    Oxon
    United Kingdom79136550001
    COULCHER, Dan Julius
    c/o Prescience
    Heddon Street
    W1B 4DA London
    14-18
    England
    Mitglied der LLP
    c/o Prescience
    Heddon Street
    W1B 4DA London
    14-18
    England
    England101328190005
    CROSS, Alan David
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Mitglied der LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    England142785540003
    CRUZ, Joseph Anthony
    Biggleswade Road
    SG18 9BD Upper Caldecote
    102
    Beds
    Mitglied der LLP
    Biggleswade Road
    SG18 9BD Upper Caldecote
    102
    Beds
    United Kingdom14619190002
    DALE-STAPLES, Ian Peter
    Midford Road
    South Stoke
    BA2 5SB Bath
    Thornton 136
    Mitglied der LLP
    Midford Road
    South Stoke
    BA2 5SB Bath
    Thornton 136
    England14471210002
    DALY, Justin
    c/o Prescience
    London End
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a
    Buckinghamshire
    England
    Mitglied der LLP
    c/o Prescience
    London End
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a
    Buckinghamshire
    England
    England150583230004
    DOOCEY, Anthony Stephen
    Dudlow Lane
    Mossley
    L18 2EZ Liverpool
    30
    Mitglied der LLP
    Dudlow Lane
    Mossley
    L18 2EZ Liverpool
    30
    England72539530001
    EGERTON, Andrew Robert
    East Gomeldon Road
    Gomeldon
    SP4 6LA Salisbury
    15
    Wiltshire
    Mitglied der LLP
    East Gomeldon Road
    Gomeldon
    SP4 6LA Salisbury
    15
    Wiltshire
    United Kingdom142462600001
    EGERTON, Oonagh
    East Gomeldon Road
    Gomeldon
    SP4 6LA Salisbury
    15
    Wiltshire
    Mitglied der LLP
    East Gomeldon Road
    Gomeldon
    SP4 6LA Salisbury
    15
    Wiltshire
    Uk142786370001
    FINLAY, William David
    Barlow Close
    Wheatley
    OX33 1NL Oxford
    21
    Oxfordshire
    Mitglied der LLP
    Barlow Close
    Wheatley
    OX33 1NL Oxford
    21
    Oxfordshire
    England135535110001
    FLETCHER, Darren Nigel
    Tarnside Close
    LU6 3PY Dunstable
    27
    Bedfordshire
    Mitglied der LLP
    Tarnside Close
    LU6 3PY Dunstable
    27
    Bedfordshire
    United Kingdom142644700001
    FORMAN, Andrew Ian
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Mitglied der LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    England51826780002
    FOXLEY, Andrew
    Pottery Lane
    Inkpen
    RG17 9QA Hungerford
    Ivy Cottage
    Berkshire
    Mitglied der LLP
    Pottery Lane
    Inkpen
    RG17 9QA Hungerford
    Ivy Cottage
    Berkshire
    United Kingdom141881640001
    FOXLEY, Paula Louise
    Pottery Lane
    Inkpen
    RG17 9QA Hungerford
    Ivy Cottage
    Berkshire
    Mitglied der LLP
    Pottery Lane
    Inkpen
    RG17 9QA Hungerford
    Ivy Cottage
    Berkshire
    England87999520002
    FYANS, Paula Therese
    c/o Prescience
    Heddon Street
    W1B 4DA London
    14-18
    England
    Mitglied der LLP
    c/o Prescience
    Heddon Street
    W1B 4DA London
    14-18
    England
    United Kingdom97281210005
    GOSWAMI, Nilash
    Tewkesbury Terrace
    N11 2LT London
    32
    Mitglied der LLP
    Tewkesbury Terrace
    N11 2LT London
    32
    United Kingdom141864320001
    HANNAM, Peter Frederick
    Bristow Close
    Bletchley
    MK2 2XP Milton Keynes
    8
    Mitglied der LLP
    Bristow Close
    Bletchley
    MK2 2XP Milton Keynes
    8
    Uk58190590002
    HANNAM, Stephen
    Cambridge Street
    Bletchley
    MK2 2TP Milton Keynes
    26
    Mitglied der LLP
    Cambridge Street
    Bletchley
    MK2 2TP Milton Keynes
    26
    United Kingdom67901030001
    HOGBIN, Christopher Edward Geroge
    Clapham Common West Side
    SW4 9AX London
    71
    Mitglied der LLP
    Clapham Common West Side
    SW4 9AX London
    71
    United Kingdom142785670001
    HOLMES, Timothy Colin
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Mitglied der LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    United Kingdom150575480001
    HOWE, Christopher Leonard
    Horn Hill
    SG4 8AR Whitwell
    58
    Hertfordshire
    Mitglied der LLP
    Horn Hill
    SG4 8AR Whitwell
    58
    Hertfordshire
    England27714390001

    Hat OMNI FILMS 3 LLP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 16. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee by way of first fixed charge all right title and interest in relation to the film provisionally entitled 'chalet girl' and all collateral allied ancillary and subsidiary rights in the film and all properties and things of value pertaining to the film and all products and proceeds of the film now or in the future made throughout the world see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chalet Girl Films Distribution LTD
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Legal charge and deed of assignment
    Erstellt am 05. Apr. 2010
    Geliefert am 26. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge all rights in relation to the motion picture currently entitled 'burke & hare', all pre-printed elements, all positive prints, all machinery, deposits, cash, insurance, literary property, copyright, all undertaking relating to the film, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Entertainment Film Distributors Limited
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 19. März 2010
    Geliefert am 29. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge all rights in relation to the motion picture currently entitled 'burke & hare', all pre-printed elements, all positive prints, all machinery, deposits, cash, insurance, literary property, copyright, all undertaking relating to the film, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aegis Film Fund Limited
    Transaktionen
    • 29. März 2010Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 03. Nov. 2009
    Geliefert am 13. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest in and to all copies made or to be made of the film all digital material any agreements all revenues the accounts all other rights first floating charge all of the undertakings rights and assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • UK Film Council
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 02. Nov. 2009
    Geliefert am 07. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the commissioning company or the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all copies made or to be made of the film currently entitled "the guard" all digital material agreements revenues accounts other rights floating charge all undertaking rights and assets in connection with the film.
    Berechtigte Personen
    • Aegis Film Fund Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 02. Nov. 2009
    Geliefert am 07. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the limited liability partnership, the commissioning company, the film production company or the third party chargors to the chargee or a third party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in all copies made or to be made of the film, currently entitled 'the guard', digital material, agreements, revenues, accounts all other rights, floating charge all undertaking rights and assets in connection with the film, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bord Scannan Na Heireann/Irish Film Board
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (LLMG01)
    • 05. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)
    Charge over dedicated security account
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 05. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns the benefit of the monies held from time to time in the dedicated security account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (LLP395)
    • 02. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (LLMR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0