OMNI FILMS 3 LLP
Überblick
| Unternehmensname | OMNI FILMS 3 LLP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Limited Liability Partnership |
| Unternehmensnummer | OC346028 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich OMNI FILMS 3 LLP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1/1a Bakery Court London End HP9 2FN Beaconsfield Buckinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OMNI FILMS 3 LLP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OMNI FILMS 3 LLP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Handelsregister | 3 Seiten | LLDS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Suber Pcs Llp als Mitglied am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2016 | 3 Seiten | LLAR01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Anthony Sharp als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von William James Wright als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Yates als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Sean Russell Williams als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Edward Wood als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Wheatley als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Peter Charles Wheeler als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Martyn Elwyn Williams als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Bernard St John Webb als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Matthew John Webb als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Craig Alyn Watkins als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Horace Walton als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Douglas Turkington als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Catherine Jane Thorn als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Timothy Charles Taylor als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Graham John Tate als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew Philip Stevens als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Brooke Marcus Stephens als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Justin Smith als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Simon Royle als Mitglied am 30. Dez. 2015 | 1 Seiten | LLTM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von OMNI FILMS 3 LLP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESCIENCE FILM FINANCE LIMITED | Bestelltes Mitglied der LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England |
| 142484570001 | ||||||||||
| SUBER PCS LLP | Bestelltes Mitglied der LLP | Ashby Road NN12 6PG Towcester 30 Ashby Road Northamptonshire England |
| 142484580003 | ||||||||||
| ALLUM, Jonathon Edward | Mitglied der LLP | Durham Road BR2 0SR Bromley 114 Kent | United Kingdom | 142173840001 | ||||||||||
| ARIYARAJNAM, Shyamala, Dr | Mitglied der LLP | Talbenny Close BL1 5FG Bolton 5 Lancashire | Uk | 150575000001 | ||||||||||
| ARIYARATNAM, Rajkumar, Dr | Mitglied der LLP | Talbenny Close BL1 5FG Bolton 5 Lancashire | United Kingdom | 150574890001 | ||||||||||
| ATKINSON, Anthony | Mitglied der LLP | Randall Road Chandler's Ford SO53 5AJ Eastleigh 37 Hampshire | United Kingdom | 142063890001 | ||||||||||
| BERTELSEN, Ole Peder | Mitglied der LLP | Brantridge Lane Balcombe RH17 6JP Haywards Heath White House | United Kingdom | 48699340001 | ||||||||||
| BITHREY, Paul Michael | Mitglied der LLP | Lighthorne Rise LU3 3XG Luton 8 Bedfordshire | England | 128951840001 | ||||||||||
| BOARDWELL, Trevor | Mitglied der LLP | Skipton Old Road BB8 7AE Colne Greystones Lancashire | England | 16987740001 | ||||||||||
| BROWELL, David | Mitglied der LLP | Anick NE46 4LW Hexham Anick Old House Northumberland United Kingdom | United Kingdom | 142227360002 | ||||||||||
| BUTTERFIELD, Geoffrey Robert | Mitglied der LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England | England | 150733400001 | ||||||||||
| CHITIRAMOHAN, Ramalingam Nirmalakumar, Dr | Mitglied der LLP | Hamilton Avenue B17 8AR Birmingham 60 West Midlands | Britain | 149771680001 | ||||||||||
| CLOUGH, Stephen John | Mitglied der LLP | East Downs Road WA14 2LQ Bowden Cransley | United Kingdom | 158703520001 | ||||||||||
| COOPER, Benjamin Joseph | Mitglied der LLP | Circle Hill Road RG45 6RN Crowthorne Granville | Uk | 142802650001 | ||||||||||
| CORCORAN, Christopher | Mitglied der LLP | Upperton Brightwell Baldwin OX49 5NY Watlington Acre View Oxon | United Kingdom | 79136550001 | ||||||||||
| COULCHER, Dan Julius | Mitglied der LLP | c/o Prescience Heddon Street W1B 4DA London 14-18 England | England | 101328190005 | ||||||||||
| CROSS, Alan David | Mitglied der LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England | England | 142785540003 | ||||||||||
| CRUZ, Joseph Anthony | Mitglied der LLP | Biggleswade Road SG18 9BD Upper Caldecote 102 Beds | United Kingdom | 14619190002 | ||||||||||
| DALE-STAPLES, Ian Peter | Mitglied der LLP | Midford Road South Stoke BA2 5SB Bath Thornton 136 | England | 14471210002 | ||||||||||
| DALY, Justin | Mitglied der LLP | c/o Prescience London End London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Buckinghamshire England | England | 150583230004 | ||||||||||
| DOOCEY, Anthony Stephen | Mitglied der LLP | Dudlow Lane Mossley L18 2EZ Liverpool 30 | England | 72539530001 | ||||||||||
| EGERTON, Andrew Robert | Mitglied der LLP | East Gomeldon Road Gomeldon SP4 6LA Salisbury 15 Wiltshire | United Kingdom | 142462600001 | ||||||||||
| EGERTON, Oonagh | Mitglied der LLP | East Gomeldon Road Gomeldon SP4 6LA Salisbury 15 Wiltshire | Uk | 142786370001 | ||||||||||
| FINLAY, William David | Mitglied der LLP | Barlow Close Wheatley OX33 1NL Oxford 21 Oxfordshire | England | 135535110001 | ||||||||||
| FLETCHER, Darren Nigel | Mitglied der LLP | Tarnside Close LU6 3PY Dunstable 27 Bedfordshire | United Kingdom | 142644700001 | ||||||||||
| FORMAN, Andrew Ian | Mitglied der LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England | England | 51826780002 | ||||||||||
| FOXLEY, Andrew | Mitglied der LLP | Pottery Lane Inkpen RG17 9QA Hungerford Ivy Cottage Berkshire | United Kingdom | 141881640001 | ||||||||||
| FOXLEY, Paula Louise | Mitglied der LLP | Pottery Lane Inkpen RG17 9QA Hungerford Ivy Cottage Berkshire | England | 87999520002 | ||||||||||
| FYANS, Paula Therese | Mitglied der LLP | c/o Prescience Heddon Street W1B 4DA London 14-18 England | United Kingdom | 97281210005 | ||||||||||
| GOSWAMI, Nilash | Mitglied der LLP | Tewkesbury Terrace N11 2LT London 32 | United Kingdom | 141864320001 | ||||||||||
| HANNAM, Peter Frederick | Mitglied der LLP | Bristow Close Bletchley MK2 2XP Milton Keynes 8 | Uk | 58190590002 | ||||||||||
| HANNAM, Stephen | Mitglied der LLP | Cambridge Street Bletchley MK2 2TP Milton Keynes 26 | United Kingdom | 67901030001 | ||||||||||
| HOGBIN, Christopher Edward Geroge | Mitglied der LLP | Clapham Common West Side SW4 9AX London 71 | United Kingdom | 142785670001 | ||||||||||
| HOLMES, Timothy Colin | Mitglied der LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England | United Kingdom | 150575480001 | ||||||||||
| HOWE, Christopher Leonard | Mitglied der LLP | Horn Hill SG4 8AR Whitwell 58 Hertfordshire | England | 27714390001 |
Hat OMNI FILMS 3 LLP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge and deed of assignment | Erstellt am 16. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Full title guarantee by way of first fixed charge all right title and interest in relation to the film provisionally entitled 'chalet girl' and all collateral allied ancillary and subsidiary rights in the film and all properties and things of value pertaining to the film and all products and proceeds of the film now or in the future made throughout the world see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge and deed of assignment | Erstellt am 05. Apr. 2010 Geliefert am 26. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge all rights in relation to the motion picture currently entitled 'burke & hare', all pre-printed elements, all positive prints, all machinery, deposits, cash, insurance, literary property, copyright, all undertaking relating to the film, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and deed of assignment | Erstellt am 19. März 2010 Geliefert am 29. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge all rights in relation to the motion picture currently entitled 'burke & hare', all pre-printed elements, all positive prints, all machinery, deposits, cash, insurance, literary property, copyright, all undertaking relating to the film, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and deed of assignment | Erstellt am 03. Nov. 2009 Geliefert am 13. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the right title and interest in and to all copies made or to be made of the film all digital material any agreements all revenues the accounts all other rights first floating charge all of the undertakings rights and assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and deed of assignment | Erstellt am 02. Nov. 2009 Geliefert am 07. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the commissioning company or the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all copies made or to be made of the film currently entitled "the guard" all digital material agreements revenues accounts other rights floating charge all undertaking rights and assets in connection with the film. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and deed of assignment | Erstellt am 02. Nov. 2009 Geliefert am 07. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the limited liability partnership, the commissioning company, the film production company or the third party chargors to the chargee or a third party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in all copies made or to be made of the film, currently entitled 'the guard', digital material, agreements, revenues, accounts all other rights, floating charge all undertaking rights and assets in connection with the film, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over dedicated security account | Erstellt am 28. Aug. 2009 Geliefert am 05. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns the benefit of the monies held from time to time in the dedicated security account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0