ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC008975 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARBUCKLE, SMITH & COMPANY LIMITED | 01. Dez. 1987 | 01. Dez. 1987 |
| ARBUCKLE SMITH (HOLDINGS) LIMITED | 09. Feb. 1914 | 09. Feb. 1914 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Waters als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Exel Nominee No 2 Limited am 10. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Exel Secretarial Services Limited am 10. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| TAYLOR, Paul | Geschäftsführer | 2a High Street Ringstead NN14 4DA Kettering Northamptonshire | England | British | 105652320001 | |||||||||
| EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED | Geschäftsführer | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 73807850002 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Sekretär | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Sekretär | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Sekretär | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| BUSH, Nicholas James | Sekretär | 50 Chester Drive HA2 7PU Harrow Middlesex | British | 69612020001 | ||||||||||
| MACRAE, James Norman | Sekretär | Burnside Cottage Gartocharn G83 8SD Alexandria Dunbartonshire | British | 719840001 | ||||||||||
| MILLS, John Michael | Sekretär | 103 Moffats Lane AL9 7RP Brookmans Park Hertfordshire | British | 193353200001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Sekretär | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Sekretär | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Geschäftsführer | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 69617780001 | |||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Geschäftsführer | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| ELLIS, Michael John | Geschäftsführer | Little Trodgers Honor End Lane, Prestwood HP16 9HG Buckinghamshire | England | British | 133791220001 | |||||||||
| GILES, Bruce Sinclair | Geschäftsführer | 50a Warwick Place CV32 5DF Leamington Spa Warwickshire England | British | 63973720001 | ||||||||||
| JOHNSTON, Geoffrey E F | Geschäftsführer | Upper Dunard Station Road G84 8LW Rhu Dunbartonshire Scotland | British | 616920001 | ||||||||||
| KIRKBY, Peter | Geschäftsführer | Newnham View Newnham Green RG27 9AS Basingstoke Hampshire | British | 22731280001 | ||||||||||
| MACRAE, James Norman | Geschäftsführer | Burnside Cottage Gartocharn G83 8SD Alexandria Dunbartonshire | Scotland | British | 719840001 | |||||||||
| OWER, James | Geschäftsführer | 33 Cantley Crescent RG11 1NU Wokingham Berkshire | British | 719860001 | ||||||||||
| PARKHILL, Thomas Cassidy | Geschäftsführer | 22 Ayr Road Giffnock G46 6RY Glasgow Lanarkshire | British | 719870001 | ||||||||||
| RUSCH, Henry | Geschäftsführer | Victoria House 161 Station Road LE9 7GF Earl Shilton Leicestershire England | British | 63973770001 | ||||||||||
| SMITH, Jamie Robert Mark | Geschäftsführer | Tanglewood 33 Woodend Drive SL5 9BD Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 74084830002 | |||||||||
| WATERS, Christopher Stephen | Geschäftsführer | 5 Five Acres WD4 9JU Kings Langley Hertfordshire | England | British | 54969250001 | |||||||||
| WILLIS, Nigel A R | Geschäftsführer | Nervelstone PA12 4DS Lochwinnoch Renfrewshire Scotland | British | 616900001 | ||||||||||
| WOODHAMS, Ernest J | Geschäftsführer | 5 Rectory Close BN20 8AQ Eastbourne East Sussex England | British | 616890001 |
Hat ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation of deposit account | Erstellt am 02. Juli 1987 Geliefert am 14. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben £300,000 deposit account held by the company with investors in industry PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 13. Aug. 1986 Geliefert am 21. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Lease granted by the city of glasgow district council in favour of the company over 5 acres and 3 1/10TH parts of an acre. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 19. Okt. 1984 Geliefert am 30. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due, or to become due not exceeding £300,000 | |
Kurze Angaben 89/99 mitchell st. Glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 19. Okt. 1984 Geliefert am 30. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Warehouse at ferry rd glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Okt. 1984 Geliefert am 26. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Steading of ground containing four hundred and eighty eight square yards or thereby lying on the west side of mitchell street, glasgow, in the city parish of glasgow and county of lanark that area of ground extending to one hundred and forty five square yards or thereby lying on the west side of mitchell street aforesaid and in said county. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 10. Okt. 1984 Geliefert am 22. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Plots of ground in glasgow first in mitchell street containing 488 sq yards and second plot 145 sq. Yards in mitchel street. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond & floating charge | Erstellt am 07. Juni 1983 Geliefert am 22. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben The whole assets of the company. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Erstellt am 07. Juni 1983 Geliefert am 20. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Standard security | Erstellt am 06. März 1980 Geliefert am 11. März 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £201,686,77 | |
Kurze Angaben Area of ground extending to 4 acres and 37 1/100TH parts of an acre in paisley, renfrew. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation | Erstellt am 09. Dez. 1975 Geliefert am 12. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Endowment policy no.1378328 Dd. 19/9/75 insd. By commercial union assurance co. LTD. On life of geoffrey edward forshaw johnston for £150,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 02. Dez. 1975 Geliefert am 05. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Advances made or to be made in terms of agreement at 24TH july & 1ST febry 1973 | |
Kurze Angaben Lease of 5.3 acres in ferry rd. Glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 19. Juni 1975 Geliefert am 08. Juli 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Warehouse premises lying to the north of thornliebank road, lanark. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0