FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC

FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer SC013958
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    • Tätigkeit von Investmentfonds (64301) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    50 Lothian Road
    Festival Square, Edinburgh
    EH3 9WJ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FINSBURY GROWTH TRUST PLC29. Apr. 199229. Apr. 1992
    SCOTTISH CITIES INVESTMENT TRUST PLC15. Jan. 192615. Jan. 1926

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2027
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis10. Jan. 2027
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung24. Jan. 2027
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis10. Jan. 2026
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 26,521,431.5
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    06. Feb. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 26,216,991.5
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    30. Jan. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 25,954,992
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    20. Jan. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Ernennung von Ms Mary Beth Christie als Direktor am 15. Jan. 2026

    2 SeitenAP01

    Eigenkapitalrückkauf.

    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    14. Jan. 2026Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Jan. 2026 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 24,958,937
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    09. Jan. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 25,234,437
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    09. Jan. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 25,608,187
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    09. Jan. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf.

    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    15. Dez. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2025

    108 SeitenAA

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 24,168,230
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    01. Dez. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 23,784,921.5
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    19. Nov. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 23,457,421.5
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Nov. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09

    Eigenkapitalrückkauf.

    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    10. Nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf.

    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    11. Nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 23,153,588.75
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 22,625,322.5
    4 SeitenSH03

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 22,858,509.5
    4 SeitenSH03

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 22,318,978
    4 SeitenSH03

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 22,028,782.5
    4 SeitenSH03
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    28. Aug. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 21,745,107.5
    4 SeitenSH03

    Eigenkapitalrückkauf. Gekaufte eigene Aktien:

    • Kapital: GBP 21,555,932.5
    4 SeitenSH03

    Wer sind die Geschäftsführer von FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FROSTROW CAPITAL LLP
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    RechtsformLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    RechtsgrundlageLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    RegistrierungsnummerOC323835
    121077800002
    ASHTON, James Robert
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish275413170001
    CHRISTIE, Mary Beth
    50 Lothian Road
    Festival Square, Edinburgh
    EH3 9WJ
    Geschäftsführer
    50 Lothian Road
    Festival Square, Edinburgh
    EH3 9WJ
    EnglandBritish,American255976620001
    CORNISH-BOWDEN, Kate
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    United KingdomBritish117949200002
    KELLY, Sandra Claire
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25 Southampton Buildings
    England
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25 Southampton Buildings
    England
    EnglandBritish263221580001
    PUREWAL, Parwinder Singh
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    EnglandBritish302712990002
    TILBIAN, Lorna Mona
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish44049090001
    FARRAR, John William Lovat
    116 Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 3EQ London
    Sekretär
    116 Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 3EQ London
    British41946740001
    SPIVEY, Hilary
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    Sekretär
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    British1846560001
    CLOSE FINSBURY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Sekretär
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    70688480002
    CLOSE INVESTMENTS LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Sekretär
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    117475800001
    REA BROTHERS LIMITED
    12 Appold Street
    EC2A 2AW London
    Sekretär
    12 Appold Street
    EC2A 2AW London
    26633510002
    ALLARD, John Peter
    Frome Farm
    BS37 6LU Old Sodbury
    South Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Frome Farm
    BS37 6LU Old Sodbury
    South Gloucestershire
    EnglandBritish5923120001
    BECKMAN, Johan Bengt Yngve
    40 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Geschäftsführer
    40 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Swedish3479000003
    BRUNDIN, Clark Lannerdahl, Dr
    28 Observatory Street
    OX2 6EW Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    28 Observatory Street
    OX2 6EW Oxford
    Oxfordshire
    British5839640005
    COLLINS, Neil Adam
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    Geschäftsführer
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    EnglandBritish115908170001
    EARL OF DARTMOUTH, Gerald Humphrey
    48 Grosvenor Square
    W1X 9AB London
    Geschäftsführer
    48 Grosvenor Square
    W1X 9AB London
    British291710001
    HARTLEY, Walter Otto
    221 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    Geschäftsführer
    221 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    British1846580001
    HAYES, Simon
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    Geschäftsführer
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United KingdomBritish199638480001
    HUNT, David Charles
    Poplar Cottage
    Coupton
    GU3 1JF Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Poplar Cottage
    Coupton
    GU3 1JF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish23176270001
    NAIRNE, Patrick Dalmahoy, Sir
    Yew Tree
    Chilson
    OX7 3HU Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Yew Tree
    Chilson
    OX7 3HU Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish27781040001
    REEVE, Michael Arthur Ferard
    138 Oakwood Court
    W14 8JL London
    Geschäftsführer
    138 Oakwood Court
    W14 8JL London
    United KingdomBritish3478970001
    RENWICK, Vanessa
    38 Wandle Road
    Wandsworth
    SW17 7DW London
    Geschäftsführer
    38 Wandle Road
    Wandsworth
    SW17 7DW London
    EnglandBritish72764200001
    TOWNSEND, John Anthony Victor
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish97263430005
    TOWNSEND, John Anthony Victor
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish97263430005
    URRY, Stewart Wallace
    Ashley Chase House
    Abbotsbury
    DT3 4JZ Weymouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    Ashley Chase House
    Abbotsbury
    DT3 4JZ Weymouth
    Dorset
    United KingdomBritish8682110002
    WARMAN, Giles William Buckland
    111 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    Geschäftsführer
    111 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    EnglandBritish770520002

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0