ABERLOUR HOUSE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ABERLOUR HOUSE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | SC025720 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABERLOUR HOUSE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ABERLOUR HOUSE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gordonstoun School Elgin IV30 5RF Morayshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABERLOUR HOUSE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABERLOUR HOUSE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Bryan Peter Williams als Geschäftsführer am 03. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Professor Bryan Peter Williams als Direktor am 03. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Hugh Spence Brown als Sekretär am 16. Mai 2018 | 2 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Bryan Peter Williams als Geschäftsführer am 01. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Yeoman als Geschäftsführer am 01. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Gerichtsbeschluss Order of court - dissolution void | 1 Seiten | OC-DV | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2012 | 7 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2013 ohne Mitgliederliste | 4 Seiten | AR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2011 | 10 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2012 ohne Mitgliederliste | 4 Seiten | AR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2010 | 10 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2011 ohne Mitgliederliste | 4 Seiten | AR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2009 | 8 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2010 ohne Mitgliederliste | 3 Seiten | AR01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Bryan Peter Williams am 01. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Yeoman am 01. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008 | 10 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ABERLOUR HOUSE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARR, George Jefferson | Sekretär | Gordonstoun School IV30 2RF Elgin Moray | British | 38294790001 | ||||||
BROWN, Hugh Spence | Sekretär | 13 Beech Brae IV30 4NS Elgin Moray | British | 40872570003 | ||||||
BROWN, James Ogg, Commander | Sekretär | The White House Duffus IV30 2QN Elgin Morayshire | British | Director | 37334700001 | |||||
SPENCER, John Robert, Squadron Leader | Sekretär | Kilcluan House IV30 8LA Elgin Morayshire | British | 50650460002 | ||||||
WHITTLE, Colin Douglas Richardson | Sekretär | 121 High Street IV36 1AB Forres | British | Solicitor | 536270001 | |||||
BUCHANAN, Ewan Craig Barr | Geschäftsführer | Mayne House IV30 3RS Elgin Morayshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 404330003 | ||||
CAUNT, Christine Janet | Geschäftsführer | 43 Park Town OX2 6SL Oxford Oxfordshire | British | Teacher | 5133580001 | |||||
DICKINSON, John Joicey | Geschäftsführer | Dipple House IV32 7QA Fochabers Moray | British | Chartered Surveyor | 1278160001 | |||||
DONALD, Charles | Geschäftsführer | Plow Green Hartley Wespall RG27 0AL Hook Hampshire | England | British | Retired | 69189660001 | ||||
DRUMMOND, Norman | Geschäftsführer | 24 Huntingdon Place EH7 4AX Edinburgh Midlothian | British | Company Director | 68147030002 | |||||
FARQUHARSON, Clodagh | Geschäftsführer | Dallas Lodge IV36 0RY Forres Moray | British | Landowner | 7047470001 | |||||
FERGUSON, James Gordon Dickson | Geschäftsführer | 25 Heriot Row EH3 6EN Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Investment Manager | 23960001 | ||||
FOGDEN, Andrew Mark | Geschäftsführer | Wardsley Farmhouse Leagram Chipping PR3 2QT Preston Lancashire | British | Director | 74942750002 | |||||
GORDON DUFF, Priscilla Margaret | Geschäftsführer | Kirkton House Drummuir AB55 3JE Keith Banffshire | Keith | British | Chartered Surveyor | 47184790001 | ||||
GRUNEBAUM, George Peter | Geschäftsführer | 352 Mclain Street Bedford Hills New York 10507 Usa | United States | American | Managing Director | 96073500001 | ||||
HILL, Caroline Elizabeth | Geschäftsführer | Taylors Wynd Clocksbriggs DD8 2TA Forfar Angus | British | Director | 1054220001 | |||||
HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne | Geschäftsführer | Gatcombe Park Hampton Fields, Minchinhampton GL6 9AT Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 69284900001 | ||||
HUNT, Flora Christine Campbell | Geschäftsführer | 39 Stratherrick Road IV2 4LF Inverness Inverness Shire | British | Solicitor | 1323300001 | |||||
INGLEBY, Moira Frances | Geschäftsführer | Invermarkie Glass AB54 4XY Huntly Aberdeenshire | British | Housewife | 45709310001 | |||||
ISMAY CHEAPE, Emma Margaret | Geschäftsführer | Middleton Fossoway KY13 6PB Kinross | British | Self Employed | 38383690001 | |||||
JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel | Geschäftsführer | Spynie Kirk House Spynie IV30 8XJ Elgin Moray | Scotland | British | Chartered Accountant | 1390490001 | ||||
LOCKE, Alasdair James Dougall | Geschäftsführer | Glenrinnes Lodge Dufftown AB55 4BS Keith Banffshire Scotland | United Kingdom | British | Chairman | 115457770001 | ||||
LUMLEY, Tessa Jocelyn | Geschäftsführer | Flat 4 10 Westbourne Gardens W2 5PU London | British | Film Producer | 85182640001 | |||||
MACDONALD, Angus Stewart | Geschäftsführer | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross & Cromarty | British | Farmer | 1220020001 | |||||
MARTIN, Hector John Bruce | Geschäftsführer | Windmill Cottage 38 High Street AB38 9QD Aberlour Banffshire | British | Solicitor | 54403370002 | |||||
MATHEWSON, George | Geschäftsführer | Netherfield Skye Of Kurr PH26 3PA Dulnain Bridge Grantown On Spey Moray | British | Retired Headmaster | 1054210001 | |||||
MITCALFE, Alan Hugh | Geschäftsführer | Milton Brodie IV36 0UA Forres Morayshire | British | Marketing Director | 8870980001 | |||||
MORGAN, Angus | Geschäftsführer | Mount Devon House FK14 7PT Dollar | British | Company Director | 1142050001 | |||||
NASH, Mark Andrew | Geschäftsführer | 54 Harbour Street IV30 5RU Hopeman Moray | Scotland | British | Management Consultant | 114921310001 | ||||
NICHOLSON, John Richard | Geschäftsführer | Romach House Dunphail IV36 2QR Forres Morayshire | United Kingdom | British | Company Director | 1054200007 | ||||
NICHOLSON, John Richard | Geschäftsführer | Mayne Lodge Mayne IV30 3SX Elgin Moray | British | Timber Merchant | 1054200001 | |||||
OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle | Geschäftsführer | Netherdale House AB53 7LE Turriff Aberdeenshire | British | Estate Manager | 45709230001 | |||||
ORD, Peter John | Geschäftsführer | Baile Na Coille Balmoral AB35 5TB Ballater Aberdeenshire | Scotland | British | Chartered Surveyor | 948580002 | ||||
RUANE, Richard James | Geschäftsführer | Willow Vale Tradespark Road IV12 5NF Nairn Nairnshire | British | Company Director | 1293210002 | |||||
SABBAN-CLARKE, James Paley | Geschäftsführer | Sandy Hill Farm Corfe Castle BH20 5JF Wareham Dorset | British | Consultant | 89104030001 |
Hat ABERLOUR HOUSE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben The whole assets of the company. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 05. Nov. 1990 Geliefert am 19. Nov. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben The whole assets of the company. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 01. Aug. 1983 Geliefert am 03. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000 & all further sums due or to become due | |
Kurze Angaben The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 25. Juli 1983 Geliefert am 29. Juli 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £75,000,00 | |
Kurze Angaben All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Disposition | Erstellt am 29. Sept. 1969 Geliefert am 02. März 1970 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £4,000 | |
Kurze Angaben New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0