ABERLOUR HOUSE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameABERLOUR HOUSE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer SC025720
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gordonstoun School
    Elgin
    IV30 5RF Morayshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Bryan Peter Williams als Geschäftsführer am 03. Okt. 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Professor Bryan Peter Williams als Direktor am 03. Okt. 2020

    2 SeitenAP01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Hugh Spence Brown als Sekretär am 16. Mai 2018

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Bryan Peter Williams als Geschäftsführer am 01. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Yeoman als Geschäftsführer am 01. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Gerichtsbeschluss

    Order of court - dissolution void
    1 SeitenOC-DV

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2013 ohne Mitgliederliste

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2011

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2012 ohne Mitgliederliste

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2011 ohne Mitgliederliste

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2010 ohne Mitgliederliste

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Bryan Peter Williams am 01. März 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Yeoman am 01. März 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARR, George Jefferson
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    Sekretär
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    British38294790001
    BROWN, Hugh Spence
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    Sekretär
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    British40872570003
    BROWN, James Ogg, Commander
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    Sekretär
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    BritishDirector37334700001
    SPENCER, John Robert, Squadron Leader
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    Sekretär
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    British50650460002
    WHITTLE, Colin Douglas Richardson
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Sekretär
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    BritishSolicitor536270001
    BUCHANAN, Ewan Craig Barr
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    Geschäftsführer
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    United KingdomBritishChartered Accountant404330003
    CAUNT, Christine Janet
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    BritishTeacher5133580001
    DICKINSON, John Joicey
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    Geschäftsführer
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    BritishChartered Surveyor1278160001
    DONALD, Charles
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    EnglandBritishRetired69189660001
    DRUMMOND, Norman
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director68147030002
    FARQUHARSON, Clodagh
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    BritishLandowner7047470001
    FERGUSON, James Gordon Dickson
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishInvestment Manager23960001
    FOGDEN, Andrew Mark
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    BritishDirector74942750002
    GORDON DUFF, Priscilla Margaret
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    Geschäftsführer
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    KeithBritishChartered Surveyor47184790001
    GRUNEBAUM, George Peter
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    Geschäftsführer
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    United StatesAmericanManaging Director96073500001
    HILL, Caroline Elizabeth
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    Geschäftsführer
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    BritishDirector1054220001
    HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector69284900001
    HUNT, Flora Christine Campbell
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    Geschäftsführer
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    BritishSolicitor1323300001
    INGLEBY, Moira Frances
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    BritishHousewife45709310001
    ISMAY CHEAPE, Emma Margaret
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    Geschäftsführer
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    BritishSelf Employed38383690001
    JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    Geschäftsführer
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    ScotlandBritishChartered Accountant1390490001
    LOCKE, Alasdair James Dougall
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    United KingdomBritishChairman115457770001
    LUMLEY, Tessa Jocelyn
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Geschäftsführer
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    BritishFilm Producer85182640001
    MACDONALD, Angus Stewart
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    Geschäftsführer
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    BritishFarmer1220020001
    MARTIN, Hector John Bruce
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    Geschäftsführer
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    BritishSolicitor54403370002
    MATHEWSON, George
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    Geschäftsführer
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    BritishRetired Headmaster1054210001
    MITCALFE, Alan Hugh
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    BritishMarketing Director8870980001
    MORGAN, Angus
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    Geschäftsführer
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    BritishCompany Director1142050001
    NASH, Mark Andrew
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    Geschäftsführer
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    ScotlandBritishManagement Consultant114921310001
    NICHOLSON, John Richard
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    United KingdomBritishCompany Director1054200007
    NICHOLSON, John Richard
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    Geschäftsführer
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    BritishTimber Merchant1054200001
    OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    BritishEstate Manager45709230001
    ORD, Peter John
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishChartered Surveyor948580002
    RUANE, Richard James
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    Geschäftsführer
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    BritishCompany Director1293210002
    SABBAN-CLARKE, James Paley
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    Geschäftsführer
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    BritishConsultant89104030001

    Hat ABERLOUR HOUSE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Bond & floating charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The whole assets of the company.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 05. Nov. 1990
    Geliefert am 19. Nov. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The whole assets of the company.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. Nov. 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (419b)
    Floating charge
    Erstellt am 01. Aug. 1983
    Geliefert am 03. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000 & all further sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    Standard security
    Erstellt am 25. Juli 1983
    Geliefert am 29. Juli 1983
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £75,000,00
    Kurze Angaben
    All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others.
    Berechtigte Personen
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transaktionen
    • 29. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Disposition
    Erstellt am 29. Sept. 1969
    Geliefert am 02. März 1970
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £4,000
    Kurze Angaben
    New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Building Society
    Transaktionen
    • 02. März 1970Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0