UA GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameUA GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC037130
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von UA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich UA GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von UA GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UNITED AUCTIONS (SCOTLAND) PUBLIC LIMITED COMPANY29. Dez. 196129. Dez. 1961

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UA GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für UA GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für UA GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Mitteilung über das Ende der Verwaltung

    13 Seiten2.23B(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    14 Seiten2.20B(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    14 Seiten2.20B(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    14 Seiten2.20B(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    13 Seiten2.20B(Scot)

    Ernennung eines Administrators

    3 Seiten2.11B(Scot)

    Mitteilung über den Antrag auf Verwaltungsanordnung

    2.2B(Scot)

    Ernennung eines Administrators

    2.11B(Scot)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    1 Seiten2.22B(Scot)

    Mitteilung über den Antrag auf Verwaltungsanordnung

    1 Seiten2.2B(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    16 Seiten2.20B(Scot)

    Vorschlag des Administrators

    80 Seiten2.16B(Scot)

    legacy

    1 Seiten2.18B(Scot)

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B(SCOT)

    18 Seiten2.15B(Scot)

    Ernennung eines Administrators

    3 Seiten2.11B(Scot)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Elphinstone House 295 Fenwick Road, Giffnock Glasgow G46 6UH* am 07. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2009 bis 30. Juni 2010

    3 SeitenAA01

    Änderung der Details des Sekretärs für John Keith Martin am 01. Juni 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für John Keith Martin am 01. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Kenneth Ross am 01. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Campbell Black am 01. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von UA GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Sekretär
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    British45302060001
    BLACK, Campbell
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritish112031270001
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish45302060001
    ROSS, Kenneth
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish41012110004
    ADAMSON, Conrad Falconer Patterson
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    Sekretär
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    British340760001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Sekretär
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Sekretär
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Sekretär
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    CAMERON, John Bell
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    Geschäftsführer
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    ScotlandBritish203550001
    DANSON, David Laurence George
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    Geschäftsführer
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    British59367160002
    DAVIDSON, Joanna Rosalind, The Hon
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    Geschäftsführer
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    British53039790001
    FRASER, Rowland Lovat
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    Geschäftsführer
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    British139690001
    GRAHAME, Joan Suzanne
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish75723440003
    HALLEY, Peter
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    British352400002
    IZAT, Alexander John Rennie
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    Geschäftsführer
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    EnglandBritish52978120002
    LEGGAT, Hugh David
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    PerthBritish686400001
    LINDSAY, James Randolph, Earl Of Lindsay
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    Geschäftsführer
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    ScotlandBritish65541090001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    MCGREGOR, Alan James Robley
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    Geschäftsführer
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    ScotlandBritish56420760001
    MCKENZIE, Norman Donald
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    Geschäftsführer
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    British686420001
    MITCHELL, Arthur Nicoll
    Leuchars Castle
    Fife
    Geschäftsführer
    Leuchars Castle
    Fife
    British641370001
    MITCHELL, Colin Henry Whiteford
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    Geschäftsführer
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    British37779160001
    MONCREIFFE, Peregrine David Euan Malcolm, Hon
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    British79267610001
    SANDERSON, Charles Russell, Lord
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    Geschäftsführer
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    ScotlandBritish1362030001
    STRACHAN, Arthur Morton
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    British74545880001
    TOUGH, Kenneth Liddell
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    Geschäftsführer
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    United KingdomBritish33189110001
    WEIR, James
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    Geschäftsführer
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    British448970001
    WIGHT, John James
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    ScotlandScottish37316580001
    YOUNG, Charles Whiteford
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    Geschäftsführer
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    British4667770001

    Hat UA GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security
    Erstellt am 13. Mai 2005
    Geliefert am 25. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond dated 9 may 2005
    Kurze Angaben
    Subjects at polmaise, stirling.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Kildean auction mart and adjacent premises, stirling.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    • 20. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    9.374 hectares at slackbuie, inverness.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    1.761 hectares at slackbuie, inverness.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Perth agricultural centre, perth.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    West haugh, stirling.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Subjects at woodmarket and abbey row, kelso.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Area of land at slackbuie, near inverness comprehending the farms of upper and lower slackbuie.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    7.975 acres at lairg on south east side of public road to from lairg to bonar bridge under exception.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Broxy kennels, redgorton, perth.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Denmarkfield, redgorton, perth.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    St. Magdalene's, perth.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Subjects at rosebank, balmoral road, rattray.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Subjects at south road, cupar known as bells brae.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    2.7 hectares at lairg.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Auction mart premises at ormlie road, thurso.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 07. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Auction mart premises at norland road, lybster, caithness.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Mart field, dalmally (title number ARG1080) and dalmally auction mart, dalmally (title number ARG1081).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Huntly auction mart, huntly (title number ABN71710).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Ground at woodlands terrace/beachan wood, grantown on spey (title number MOR3360).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Farm and lands of milton of banniskirk, near thurso, caithness.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Subjects at glenshellach, oban.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due in terms of the personal bond
    Kurze Angaben
    Lands of moleigh, oban.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (410)
    Standard security
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 29. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000
    Kurze Angaben
    7.88 acres at torbrex, st. Ninians, stirling lying to the south of torbrex road, stirling bounded to the south or southmost by the farm and lands of coxithill (otherwise coxet hill) owned by the firm of john oswald and son, which area of ground is shown delineated in red on the plan annexed and signed as relative to the standard security recorde 12TH july 1994.
    Berechtigte Personen
    • Wimpey Homes Holdings Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 1994Registrierung einer Belastung (410)
    • 22. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 23. Mai 1988
    Geliefert am 27. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Cattlemarket at caledonia road and elibank street, perth (part of lands of greenyards) 296/302 high street, perth ground immediately to west of 296/302 high street, perth ground at high street, perth (formerly 316/320 high street, perth) "clayholes" at high street/elibank street, perth ground at high street/elibank street, perth.
    Berechtigte Personen
    • Ccl LTD
    Transaktionen
    • 27. Mai 1988Registrierung einer Belastung

    Hat UA GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Sept. 2010Beginn der Verwaltung
    01. Sept. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praktiker
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praktiker
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    2
    DatumTyp
    24. Sept. 2010Beginn der Verwaltung
    27. Sept. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praktiker
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praktiker
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0