HIGHLAND CAR CLUB LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HIGHLAND CAR CLUB LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | SC040743 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
- Sonstige Sporttätigkeiten (93199) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness Highland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Juli 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Apr. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Apr. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 01. Mai 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Apr. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2024 | 5 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Ernennung von Mr Charles Munro als Sekretär am 01. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP03 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Robert Forsyth als Sekretär am 31. Jan. 2025 | 1 Seiten | TM02 | ||||||
Ernennung von Mr Stewart Hurst als Direktor am 31. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Douglas Jardine als Geschäftsführer am 31. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David James Fraser am 22. Okt. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2023 | 8 Seiten | AA | ||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Joan Elizabeth Tracey am 22. Feb. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew George Straube am 16. Dez. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||
Ernennung von Mr Mark Robert Forsyth als Sekretär am 26. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Tracy Angela Smith als Sekretär am 26. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Tracy Angela Smith am 26. Okt. 2023 | 1 Seiten | CH03 | ||||||
| ||||||||
Ernennung von Mr Gavin Maxwell Kelt als Direktor am 26. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Mr Fraser Frederick Hughes als Direktor am 26. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Mr Peter Neil Macinnes als Direktor am 26. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Ms Lucy Mary Munro als Direktor am 26. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Tracy Angela Smith als Geschäftsführer am 26. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Ricky Finlayson als Geschäftsführer am 26. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2022 | 9 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Maxwell Kelt als Geschäftsführer am 01. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Ernennung von Ms Susan Una Macrae als Direktor am 27. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Ms Joan Elizabeth Tracey als Direktor am 27. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNRO, Charles | Sekretär | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | 331866550001 | |||||||
| DAVIDSON, Wilma | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 208137880001 | |||||
| FORSYTH, Derek | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | Scottish | 192631130002 | |||||
| FORSYTH, Mark Robert | Geschäftsführer | Bishop Kinkell Conon Bridge IV7 8AW Dingwall Beinn Fhada Ross-Shire Scotland | Scotland | Scottish | 208137900001 | |||||
| FRASER, David James | Geschäftsführer | Cullaird Road IV2 4DL Inverness 13 Scotland | Scotland | British | 302570440001 | |||||
| FRASER, Robin Michael | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent IV2 6GT Inverness 15 Scotland | Scotland | Scottish | 265926380001 | |||||
| HUGHES, Fraser Frederick | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 315374280001 | |||||
| HURST, Stewart | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | Scottish | 329114810001 | |||||
| KELT, Gavin Maxwell | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 275999000001 | |||||
| LAWTON, Peter David | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 131108820001 | |||||
| MACINNES, Peter Neil | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 315374200001 | |||||
| MACRAE, Susan Una | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | Scottish | 302570720001 | |||||
| MOIR, Fiona | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent IV2 6GT Inverness 15 Scotland | Scotland | British | 192633080001 | |||||
| MUNRO, Charles Roderick | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland Scotland | Scotland | British | 43533470001 | |||||
| MUNRO, Fiona | Geschäftsführer | 15 Cedarwood Crescent IV2 6GT Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 116839740001 | |||||
| MUNRO, Lucy Mary | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | United Kingdom | British | 315374120001 | |||||
| ROSS, John | Geschäftsführer | Milton Of Clava Culloden Moor IV1 2EL Inverness Inverness Shire Scotland | Scotland | British | 27214040001 | |||||
| STRAUBE, Andrew George | Geschäftsführer | Smith Avenue IV3 5ES Inverness 23 Scotland | Scotland | Scottish | 302570370001 | |||||
| TRACEY, Joan Elizabeth | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | Scottish | 302570600002 | |||||
| FORSYTH, Mark Robert | Sekretär | Bishop Kinkell Conon Bridge IV7 8AW Dingwall Beinn Fhada Ross-Shire Scotland | 317181250001 | |||||||
| MOIR, Fiona | Sekretär | 34 Souter Drive IV2 4XJ Inverness | British | 79802320001 | ||||||
| MUNRO, Fiona | Sekretär | 15 Cedarwood Crescent IV2 6GT Inverness Inverness Shire | British | 116839740001 | ||||||
| MUNRO, Fiona | Sekretär | 15 Cedarwood Crescent IV2 6GT Inverness Inverness Shire | British | 116839740001 | ||||||
| SMITH, Tracy Angela | Sekretär | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | 208137890002 | |||||||
| WHYTE, Karen | Sekretär | Achmony Culburnie Kiltarlity Inverness Highland Scotland | British | 48362640001 | ||||||
| ADAMS, Bruce David | Geschäftsführer | 18 Bellfield Road North Kessock IV1 1XU Inverness Highland | British | 39190480001 | ||||||
| AFEK, Ian | Geschäftsführer | 14 Drumdevan Road IV2 4DB Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 127472700001 | |||||
| BAXTER, Colin Hay | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 149922910001 | |||||
| BEATON, Keir Alexander | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | British | 208137910001 | |||||
| BEATON, Keir | Geschäftsführer | 17 Ferntower Avenue IV2 7EY Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 127472640001 | |||||
| BEATON, Paul James | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland | Scotland | Scottish | 116839450002 | |||||
| BEATON, Paul James | Geschäftsführer | 17 Teal Avenue IV2 3TB Inverness | Scotland | Scottish | 116839450002 | |||||
| BLANCHARD, Carol | Geschäftsführer | 16 Corrie Terrace IV6 7QR Muir Of Ord Ross Shire | British | 27214140002 | ||||||
| BROWN, Dougal Hugo | Geschäftsführer | Cedarwood Crescent Milton Of Leys IV2 6GT Inverness 15 Highland Scotland | Scotland | Scottish | 169121740001 | |||||
| BRUCE, Adrian | Geschäftsführer | Solas Carr Road PH23 3AD Carr Bridge Inverness Shire | British | 56814370002 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HIGHLAND CAR CLUB LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 17. Apr. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0