CTP DAVALL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCTP DAVALL LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC045786
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CTP DAVALL LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CTP DAVALL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o C/O BRUNTONS AERO PRODUCTS LIMITED
    Units 1-3 Block 1 Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Midlothian
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CTP DAVALL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CTP DAVALL SCOTLAND LIMITED23. Okt. 199723. Okt. 1997
    DAVALL (SCOTLAND) LIMITED26. Okt. 199426. Okt. 1994
    MGC LIMITED05. Juni 198605. Juni 1986
    INCASE(U.K.)LIMITED03. Juli 196803. Juli 1968

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CTP DAVALL LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CTP DAVALL LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis22. Juni 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung06. Juli 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis22. Juni 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für CTP DAVALL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2025

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Ian Alan Tichias als Direktor am 01. Apr. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Eric George Hutchinson als Geschäftsführer am 31. März 2025

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2024

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Carclo Plc as a person with significant control on 14. Juni 2024

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von David Michael Bedford als Geschäftsführer am 21. Aug. 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Eric George Hutchinson als Direktor am 21. Aug. 2023

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Angela Wakes als Sekretär am 03. Aug. 2023

    1 SeitenTM02

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    37 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    That the conduct of the directors in acting and passing resolutions as directors of the company to adopt the new articles is ratified in accordance with the provisions of section 239 of the act 21/07/2023
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Lee George Westgarth als Geschäftsführer am 12. Mai 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023

    5 SeitenAA

    Ernennung von Mr David Michael Bedford als Direktor am 14. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Franciscus Lodewijk Paulus Doorenbosch als Direktor am 07. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Ian Burgess Sanders als Geschäftsführer am 05. Nov. 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Carclo Plc as a person with significant control on 16. Nov. 2021

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Nicholas Durkin-Jones als Geschäftsführer am 17. Dez. 2020

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CTP DAVALL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOORENBOSCH, Franciscus Lodewijk Paulus
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    NetherlandsDutch249600450001
    TICHIAS, Ian Alan
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish334271160001
    COLE, Richard Andrew
    PO BOX 88
    27 Dewsbury Road
    WF5 9WS Ossett
    Springstone House
    England
    Sekretär
    PO BOX 88
    27 Dewsbury Road
    WF5 9WS Ossett
    Springstone House
    England
    262028660001
    COOK, Eric
    15 Chevet Lane
    Sandal
    WF2 6HN Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    15 Chevet Lane
    Sandal
    WF2 6HN Wakefield
    West Yorkshire
    British34100510003
    MCGREGOR, Ann
    Mossburn Avenue
    Harthill
    ML7 5 Shotts
    Sekretär
    Mossburn Avenue
    Harthill
    ML7 5 Shotts
    British37430001
    MUIR, John Brown
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    British37460001
    OTTAWAY, Richard
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Scotland
    Sekretär
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Scotland
    199253570001
    WAKES, Angela
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Sekretär
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    263105330001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish106771550001
    ALLAN, Gary Alexander
    1a Carron Place
    FK7 0PN Stirling
    Geschäftsführer
    1a Carron Place
    FK7 0PN Stirling
    British55198350001
    BEDFORD, David Michael
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish302295360001
    BRADBURY, Nigel
    8 Kilton Court
    Aldbrough St. John
    DL11 7TX Richmond
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Kilton Court
    Aldbrough St. John
    DL11 7TX Richmond
    North Yorkshire
    EnglandBritish160636770002
    BROOKSBANK, Robert James
    The Manor House
    East Appleton
    DL10 7QE Richmond
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    East Appleton
    DL10 7QE Richmond
    North Yorkshire
    EnglandBritish68910300001
    CHALKLEY, Ronald Michael
    2 Apple Tree Close
    SG18 8NF Biggleswade
    Bedfordshire
    England
    Geschäftsführer
    2 Apple Tree Close
    SG18 8NF Biggleswade
    Bedfordshire
    England
    British27201840001
    COOK, Eric
    15 Chevet Lane
    Sandal
    WF2 6HN Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Chevet Lane
    Sandal
    WF2 6HN Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish34100510003
    DEAR, Peter Alfred
    Meadow Cottage Kinsbourne Green
    AL5 3PZ Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Meadow Cottage Kinsbourne Green
    AL5 3PZ Harpenden
    Hertfordshire
    British11401200002
    DUGARD, Frederick Jeremy
    40 Cuckoo Hill Road
    HA5 1AX Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    40 Cuckoo Hill Road
    HA5 1AX Pinner
    Middlesex
    British11401210001
    HASLEHURST, Peter Joseph Kinder
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Crowholt Farm
    Cowbrook Lane Gawsworth
    SK11 0JH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish39820040001
    HAY, Alexander Donald
    9 Woodbank Crofts
    Westfield
    EH48 3AT Armadale
    West Lothian
    Geschäftsführer
    9 Woodbank Crofts
    Westfield
    EH48 3AT Armadale
    West Lothian
    British73266530001
    HOBBS, Jeffrey Jacques
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Cedar Copse
    BR1 2NY Bromley
    Kent
    British3252730001
    HUTCHINSON, Eric George
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    United KingdomBritish278361460001
    KURWIE, Tiessir Shhab
    6 Kensington Road
    WF1 3JX Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Kensington Road
    WF1 3JX Wakefield
    West Yorkshire
    British63799580002
    MALLEY, Christopher John
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish244827890001
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCGREGOR, Ian
    3 New Edinburgh Road
    Uddingston
    G71 6BT Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    3 New Edinburgh Road
    Uddingston
    G71 6BT Glasgow
    Lanarkshire
    British75699500001
    MCILRAITH, Douglas
    11 Baird Crescent
    Balloch
    G67 4BZ Glasgow
    Geschäftsführer
    11 Baird Crescent
    Balloch
    G67 4BZ Glasgow
    British47795570001
    MUIR, John Brown
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    British37460001
    MUIR, John Brown
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    33 Parkburn Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4AD Glasgow
    Lanarkshire
    British37460001
    OTTAWAY, Richard John
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish183149280001
    REVILL, John Arthur
    43 Haworth Crescent
    Moorgate
    S60 3BW Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    43 Haworth Crescent
    Moorgate
    S60 3BW Rotherham
    South Yorkshire
    British39565760003
    SALT, Roger
    55 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RT Dronfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    55 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RT Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish172092330001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    United KingdomBritish83283880002
    THEWLIS, Matthew John
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish266339080002
    WAKES, Angela
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish265760920001
    WESTGARTH, Lee George
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    Geschäftsführer
    c/o C/O Bruntons Aero Products Limited
    Inveresk Industrial Estate
    EH21 7PA Musselburgh
    Units 1-3 Block 1
    Midlothian
    EnglandBritish262033110002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CTP DAVALL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Carclo Plc
    Wates Way
    CR4 4HR Mitcham
    47
    Surrey
    United Kingdom
    06. Apr. 2017
    Wates Way
    CR4 4HR Mitcham
    47
    Surrey
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPlc
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0