BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC070250 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BDO LLP 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow Scotland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Barry John Head als Direktor am 08. Dez. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Warwick Lawrence als Geschäftsführer am 17. Okt. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jenna House, 6 Mollins Court Westfield Industrial Estate Cumbernauld Glasgow G68 9HP am 26. März 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATH, Kameljit | Sekretär | 111 Linceslade Grove MK5 8AD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 93238530001 | ||||||
| HEAD, Barry John | Geschäftsführer | c/o Crown Products (Kent) Ltd Eddington Lane CT6 5TR Herne Bay Eddington Works Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 34360800002 | |||||
| DONALDSON, Brian James | Sekretär | 4 Pattle Place Alloway KA7 4PS Ayr Ayrshire | British | 261950002 | ||||||
| HUTCHINSON, Timothy | Sekretär | Heron House Ranby DN22 8HR Retford | British | 88382490001 | ||||||
| STEEL, Steven John | Sekretär | 16 Thornton Close Crick NN6 7GE Northampton Northamptonshire | British | 109982220001 | ||||||
| CHRISTIE, George Henry | Geschäftsführer | Cheviot 10 Little Carron Gardens KY16 8QL St. Andrews Fife | British | 64544730001 | ||||||
| DONALDSON, Brian James | Geschäftsführer | 4 Pattle Place Alloway KA7 4PS Ayr Ayrshire | British | 261950002 | ||||||
| DONALDSON, Rosemary | Geschäftsführer | 4 Pattle Place Alloway KA7 4PS Ayr Ayrshire | British | 261960002 | ||||||
| HUNTER, David Jeffrey | Geschäftsführer | 7 Wolfe Avenue Crookfur G77 6TQ Newton Mearns Glasgow | Scotland | British | 205080800001 | |||||
| HUTCHINSON, Timothy | Geschäftsführer | Heron House Ranby DN22 8HR Retford | United Kingdom | British | 88382490001 | |||||
| LAWRENCE, Michael Warwick | Geschäftsführer | Rectory Grange Petsoe End MK46 5JL Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | 33280980005 | |||||
| STEEL, Steven John | Geschäftsführer | 16 Thornton Close Crick NN6 7GE Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 109982220001 | |||||
| WHITELAW, Alexander John | Geschäftsführer | Ardbeg Barnkittock, Comrie Road PH7 4BQ Crieff Perth & Kinross | British | 88092080001 |
Hat BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Erstellt am 02. Mai 2000 Geliefert am 10. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The whole monetary and other obligations as contained in the agreement | |
Kurze Angaben All or any debts owing or accruing to the company now or at any time hereafter (and all rights relative thereto) which are or are purported to be subject to the agreement but in respect of which title has not passed to and vested in rbif or to which rbif is not otherwise absolutely entitled and which are or may be from time to time while the charge is in force comprised in the company's property and undertaking. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 06. Sept. 1985 Geliefert am 20. Sept. 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 2 semi-detached factories known as 6 & 8 glenfield road. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 21. Aug. 1985 Geliefert am 09. Sept. 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 6 & 8 glenfield road, east kilbride. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 20. Juni 1983 Geliefert am 28. Juni 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 8 glenfield rd, east kilbride. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond & floating charge | Erstellt am 11. Sept. 1981 Geliefert am 22. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset | Erstellt am 19. Mai 1980 Geliefert am 23. Mai 1980 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys due, or to become due to the chargee by the company & B.J.D. kitchens & bathrooms LTD | |
Kurze Angaben Balances at credit of any account or accounts in name of brian donaldson distribution LTD. Held by the governor and company of the bank of scotland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0