NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED

NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC082005
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    • See- und Küstenpassagierverkehr (50100) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SWEDISH CALEDONIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED01. März 198301. März 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis06. Nov. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung20. Nov. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis06. Nov. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Michael Kierney als Sekretär am 07. Jan. 2026

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ronald Stewart als Sekretär am 07. Jan. 2026

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    33 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Nov. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Murdoch John Macdonald als Geschäftsführer am 30. Sept. 2025

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung SC0820050022, erstellt am 30. Sept. 2025

    36 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von Alastair Fleming als Geschäftsführer am 12. Aug. 2025

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung SC0820050021, erstellt am 30. Juni 2025

    40 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung SC0820050010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung SC0820050020, erstellt am 12. Juni 2025

    7 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung SC0820050019, erstellt am 30. Mai 2025

    40 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung SC0820050013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC0820050014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung SC0820050018, erstellt am 07. Mai 2025

    7 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung SC0820050017, erstellt am 31. März 2025

    37 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    30 SeitenAA

    Ernennung von Mr John Douglas Cook als Direktor am 29. Jan. 2025

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Ronald Stewart als Sekretär am 30. Okt. 2024

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gael Edgar Mccallum als Sekretär am 13. Aug. 2024

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Charalampos Prokopiou als Geschäftsführer am 28. Juni 2024

    1 SeitenTM01

    Change of details for Nmg Ship Management Ltd as a person with significant control on 27. März 2024

    2 SeitenPSC05

    Ernennung von Ms Gael Edgar Mccallum als Sekretär am 14. März 2024

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Charalampos Prokopiou als Direktor am 12. Jan. 2024

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung SC0820050015, erstellt am 08. Feb. 2024

    40 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KIERNEY, Michael
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    344048000001
    COOK, John Douglas
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    EnglandBritish285563060001
    HACKETT, Michael
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish298785790001
    BEATSON, William Johnston
    35 Pelstream Avenue
    FK7 0BG Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    Sekretär
    35 Pelstream Avenue
    FK7 0BG Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    British35466310001
    CAIRNEY, Ronald John
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    263947690001
    COWAN, Jonathan
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    295808940001
    GRAY, Douglas
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    193768490001
    MACLEOD, Kenneth
    5 Belleisle Place
    PA19 1HZ Gourock
    Renfrewshire
    Sekretär
    5 Belleisle Place
    PA19 1HZ Gourock
    Renfrewshire
    British153790001
    MCCALLUM, Gael Edgar
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House, 2 Central Avenue
    Scotland
    Sekretär
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House, 2 Central Avenue
    Scotland
    320511680001
    STEWART, Ronald
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    328813120001
    TIERNEY, Jacqueline May
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Sekretär
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    British102974270001
    BEATSON, William Johnston
    35 Pelstream Avenue
    FK7 0BG Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    35 Pelstream Avenue
    FK7 0BG Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    British35466310001
    BERGLUND, Mats
    Davelundsg 16
    Vastra Frolunda
    42677
    Sweden
    Geschäftsführer
    Davelundsg 16
    Vastra Frolunda
    42677
    Sweden
    Swedish74933350001
    BRYDON, Alistair John Douglas
    10 Friarsdene
    ML11 9EJ Lanark
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    10 Friarsdene
    ML11 9EJ Lanark
    South Lanarkshire
    ScotlandBritish153800001
    BURNETT, Carl Joseph
    Beech Coppice
    Woodland Way
    KT20 6NW Kingswood
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beech Coppice
    Woodland Way
    KT20 6NW Kingswood
    Surrey
    American29841020001
    BYSTEDT, Stig Reinhold
    6 Vallgaangen
    FOREIGN Uddevalla
    Sweden
    Geschäftsführer
    6 Vallgaangen
    FOREIGN Uddevalla
    Sweden
    Swedish153840001
    CARLSSON, Lars Eric
    9 Gamla Kyrkstigen
    FOREIGN Saeroe
    Sweden
    Geschäftsführer
    9 Gamla Kyrkstigen
    FOREIGN Saeroe
    Sweden
    Swedish153830001
    CARLSSON, Svante Wilhelm
    Hallandsgatan 3
    S 41139 Gothenburg
    Sweden
    Geschäftsführer
    Hallandsgatan 3
    S 41139 Gothenburg
    Sweden
    SwedenSwedish21485110001
    COWDEN, Douglas
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish211440330001
    DAVIDSON, Claes
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    SwedenSwedish94597360001
    EHRET, Thomas Michel Ernest
    28 Forrest Road
    AB2 4BS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    28 Forrest Road
    AB2 4BS Aberdeen
    Aberdeenshire
    French20962190001
    FERGUSON, Hugh Linden
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish94308110001
    FLEMING, Alastair
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish296551130001
    FRASER, Robert William Alexander
    51 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    51 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LB Edinburgh
    Midlothian
    British155160001
    FULLERTON, Philip William Boyd
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Northern IrelandBritish134191530001
    HARDING, John Frederick
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish134191990001
    HILLER, Knut Torsten Lennart
    12 Berzeliigatan
    FOREIGN Gothenburg
    Sweden
    Geschäftsführer
    12 Berzeliigatan
    FOREIGN Gothenburg
    Sweden
    Swedish153820001
    HULTGREN, Staffan Werner
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    SwedenSwedish119721530001
    JAWERT, Johan
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    SwedenSwedish250868970001
    MACDONALD, Murdoch John
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish134191180001
    MACLEOD, Kenneth
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish153790003
    MCCONNELL, John Kenneth
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish183978270001
    MCCORMACK, Barry Sean
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandBritish228554520001
    PROKOPIOU, Charalampos
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    Geschäftsführer
    Alba House
    2 Central Avenue
    G81 2QR Clydebank Scotland
    ScotlandGreek320123340001
    PSILANDER, Carl-Axel Folke
    Patron Haroldsvaeg
    Lidingoe
    Sweden
    Geschäftsführer
    Patron Haroldsvaeg
    Lidingoe
    Sweden
    Swedish153810001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORTHERN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Nmg Ship Management Ltd
    Arlington Street
    SW1A 1RE London
    9
    England
    06. Apr. 2016
    Arlington Street
    SW1A 1RE London
    9
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer03251676
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0