CLYDE MARINE TRAINING LIMITED

CLYDE MARINE TRAINING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCLYDE MARINE TRAINING LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC100124
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    • Sonstige Bildung n.n.g. (85590) / Erziehung

    Wo befindet sich CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Alba House 2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FALBREAK LIMITED18. Juli 198618. Juli 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Apr. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung21. Apr. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Apr. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Hugh Innes Rapson als Direktor am 07. Jan. 2026

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ronald Stewart als Sekretär am 07. Jan. 2026

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Michael Kierney als Sekretär am 07. Jan. 2026

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2025 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    13 SeitenAA

    Cessation of The Clyde Group Ltd as a person with significant control on 01. Feb. 2025

    1 SeitenPSC07

    Ernennung von Mr Ronald Stewart als Sekretär am 22. Okt. 2024

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Gael Edgar Mccallum als Sekretär am 13. Aug. 2024

    1 SeitenTM02

    Notification of Nmg Marine Services Ltd as a person with significant control on 05. Juni 2024

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Philip William Boyd Fullerton als Direktor am 20. März 2024

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Richard Abate als Geschäftsführer am 20. März 2024

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Gael Edgar Mccallum als Sekretär am 14. März 2024

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Cowan als Sekretär am 04. Jan. 2024

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    18 SeitenAA

    Ernennung von Mr Jonathan Cowan als Sekretär am 13. Mai 2022

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ronnie Cairney als Sekretär am 13. Mai 2022

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr John Richard Abate als Direktor am 30. Nov. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ronald John Cairney als Geschäftsführer am 30. Nov. 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KIERNEY, Michael
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    344048210001
    FULLERTON, Philip William Boyd
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Northern IrelandBritish134191530001
    RAPSON, Hugh Innes
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandScottish273230390001
    CAIRNEY, Ronnie
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    264952110001
    COWAN, Jonathan
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    295808380001
    DOWNIE, Joyce
    71 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    Sekretär
    71 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    British75495850001
    FEE, Peter Francis
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    193026260001
    GRAY, Douglas
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    257984990001
    LIVINGSTONE, David James Duncan
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    Sekretär
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    British49738800002
    LIVINGSTONE, Karen
    11 Kingsway Place
    Clerkenwell
    EC1R 0LU London
    Sekretär
    11 Kingsway Place
    Clerkenwell
    EC1R 0LU London
    British95718550001
    LIVINGSTONE, Sissel
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    Sekretär
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    British57680480001
    MCCALLUM, Gael Edgar
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House, 2
    Scotland
    Sekretär
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House, 2
    Scotland
    320513330001
    STEWART, Ronald
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Sekretär
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    328515390001
    WRAY, Andrew Robert
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Sekretär
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    British116557770001
    ABATE, John Richard
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish140500780001
    CAIRNEY, Ronald John
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish270393970001
    DOWNIE, Joyce
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Geschäftsführer
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    ScotlandBritish75495850001
    FEE, Peter Francis
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish187322220001
    GIBB, William David
    24 Cairnhill Road
    Bearsden
    G61 1AU Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    24 Cairnhill Road
    Bearsden
    G61 1AU Glasgow
    Lanarkshire
    British14507600001
    LIVINGSTONE, David James Duncan
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    Geschäftsführer
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    ScotlandBritish49738800002
    LIVINGSTONE, Sissel
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    Geschäftsführer
    1 Heathfield Drive
    Milngavie
    G62 8AZ Glasgow
    British57680480001
    MCMURRAY, Colin Andrew
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    2 Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    West Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish127759980002
    THOMAS, George Leonard
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Geschäftsführer
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    United KingdomBritish134949490001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CLYDE MARINE TRAINING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    Scotland
    05. Juni 2024
    Central Avenue
    Clydebank Business Park
    G81 2QR Clydebank
    Alba House
    Scotland
    Nein
    RechtsformCorporation
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc488390
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Staffan Werner Hultgren
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    05. Mai 2016
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Ja
    Nationalität: Swedish
    Staatsangehörigkeit: Sweden
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Scotland
    06. Apr. 2016
    Seaforth Road North
    Hillington Park
    G52 4JQ Glasgow
    Seaforth House
    Scotland
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUnited Kingdom
    RegistrierungsnummerSc481645
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0