MONO GROUP
Überblick
| Unternehmensname | MONO GROUP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | SC107956 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MONO GROUP?
- (9999) /
Wo befindet sich MONO GROUP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | National Oilwell Varco Uk Ltd Badentoy Crescent Badentoy Industrial Estate AB12 4YD Portlethen Aberdeen |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MONO GROUP?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DMWS 68 LIMITED | 30. Nov. 1987 | 30. Nov. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONO GROUP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MONO GROUP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Ernennung von Alastair James Fleming als Sekretär am 30. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Paul O'neil als Sekretär am 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Keener als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Christopher Paul O'neil als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von David James Keener als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Boyle als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Douglas Boyle am 13. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 28 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Leighton als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Naylon am 13. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Christopher Paul O'neil als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MONO GROUP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMING, Alastair James | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163563910001 | |||||||
| NAYLON, Paul | Geschäftsführer | 338 Newton Road Lowton WA3 1HE Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 28875970001 | |||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Geschäftsführer | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| VALENTINE, Steven Grenville | Geschäftsführer | 4 Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe | England | British | 92773870002 | |||||
| FLETCHER, Anthony Trevor | Sekretär | Higher Oaklands Farm House Barrowford BB9 6QZ Nelson | British | 113788270001 | ||||||
| LEIGHTON, Katherine Jennifer | Sekretär | Kirk House Victoria Terrace, Kemnay AB51 5RL Inverurie Aberdeenshire | British | 110703040002 | ||||||
| MATHER, Melanie Gay | Sekretär | 2717 Luella 77536 Deer Park Texas Usa | American | 92773820001 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Sekretär | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire | British | 146000450001 | ||||||
| TORKINGTON, John Robert | Sekretär | 2 Barwell Close Reddish SK5 6YF Stockport Cheshire | British | 35453200001 | ||||||
| BODDINGTON, Kenneth William | Geschäftsführer | 4 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | 1343490001 | ||||||
| BOYLE, Thomas Douglas | Geschäftsführer | Lanark Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen | Uk | British | 61611910001 | |||||
| CAMP, Glenn Bryan | Geschäftsführer | 19 Hough Lane Gristhorpe SK9 2LQ Wilmslow Cheshire | American | 54147750001 | ||||||
| FITZGERALD, Mel Oliver | Geschäftsführer | 3 Marlyns Drive Burpham GU4 7LS Guildford Surrey | United Kingdom/England | Irish | 69993790001 | |||||
| FLETCHER, Anthony Trevor | Geschäftsführer | Higher Oaklands Farm House Barrowford BB9 6QZ Nelson | British | 113788270001 | ||||||
| GARVEY, William | Geschäftsführer | 1 Chapel Brow Broadbottom SK14 6HH Hyde Cheshire | British | 590690001 | ||||||
| GARVEY, William | Geschäftsführer | 1 Chapel Brow Broadbottom SK14 6HH Hyde Cheshire | British | 590690001 | ||||||
| HARRISON, Michael | Geschäftsführer | 126 Manchester Road Chapel En Le Frith SK12 6TP Stockport Cheshire England | England | British | 86410610001 | |||||
| HERBERT, John Shotton | Geschäftsführer | Michelend Lewes Road, Westmeston BN6 8RH Hassocks West Sussex | British | 81675020001 | ||||||
| HOUSTON, John Joseph | Geschäftsführer | 3 Kinmundy Avenue AB32 6TG Westhill Aberdeenshire | Scotland | British | 81041240001 | |||||
| HUGHES, Emyr Tonlas | Geschäftsführer | Danesbury 50 Byng Drive EN6 1UF Potters Bar Hertfordshire | British | 40119990001 | ||||||
| KASH, John | Geschäftsführer | 57 Aspen Drive FOREIGN Basking Ridge New Jersey Usa | American | 9489980001 | ||||||
| KEENER, David James | Geschäftsführer | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | 161469350001 | |||||
| KENNEDY, Michael James | Geschäftsführer | 15 Heathway CR3 5DN Caterham Surrey | British | 54147870002 | ||||||
| KRABLIN, Steven Wayne | Geschäftsführer | 9619 Windrush Drive 77379 Spring Texas Usa | Usa | United States | 69886740001 | |||||
| MATHEWSON, Lindsay Thomas | Geschäftsführer | 21 Macclesfield Road SK17 9AH Buxton Derbyshire | British | 590700001 | ||||||
| MOLLER, Leslie George | Geschäftsführer | 12 Chester Court Chester Road HA6 1BQ Northwood Middlesex | England | British | 63570320001 | |||||
| NICHOLSON, Stephen John | Geschäftsführer | 48 Wolseley Gardens W4 3LS London | British | 3042100001 | ||||||
| OCONNOR, William Evans | Geschäftsführer | Gristhorpe 19 Hough Lane SK9 2LQ Wilmslow Cheshire | Us Citizen | 13102020001 | ||||||
| SPEIRS, John Garrett | Geschäftsführer | 20 Dunstall Road Wimbledon SW20 0HR London | England | British | 428480001 | |||||
| TOCHER, Judith Robertson | Geschäftsführer | Blacktop House, Blacktop Kingswells AB15 8QJ Aberdeen | United Kingdom | British | 82086030001 | |||||
| WHITE, Philip Arthur Laxton | Geschäftsführer | 15 Bedford Street Stockton Heath WA4 6LY Warrington Cheshire | British | 13102030001 |
Hat MONO GROUP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Juni 1988 Geliefert am 28. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben (A) by way of third fixed charge all the property (if any) specified in the first schedule of the debenture together with all buildings and fixtures (as hereinafter defined) thereon and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in performance of such covenants; (b) by way of third fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Juni 1988 Geliefert am 16. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 1. by way of second fixed charge all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of second fixed charge: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon), rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of second fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Juni 1988 Geliefert am 16. Juni 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 1. by way of first legal mortgage all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of first legal mortgage: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of first fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0