MONO GROUP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMONO GROUP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer SC107956
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MONO GROUP?

    • (9999) /

    Wo befindet sich MONO GROUP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    National Oilwell Varco Uk Ltd Badentoy Crescent
    Badentoy Industrial Estate
    AB12 4YD Portlethen
    Aberdeen
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MONO GROUP?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DMWS 68 LIMITED30. Nov. 198730. Nov. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONO GROUP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MONO GROUP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Ernennung von Alastair James Fleming als Sekretär am 30. Sept. 2011

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Christopher Paul O'neil als Sekretär am 30. Sept. 2011

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Keener als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Christopher Paul O'neil als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von David James Keener als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Boyle als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 21. Juni 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Douglas Boyle am 13. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    28 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share premium account 17/12/2010
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Katherine Leighton als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Naylon am 13. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Christopher Paul O'neil als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Wer sind die Geschäftsführer von MONO GROUP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Sekretär
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163563910001
    NAYLON, Paul
    338 Newton Road
    Lowton
    WA3 1HE Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    338 Newton Road
    Lowton
    WA3 1HE Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish28875970001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Geschäftsführer
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritish92773870002
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    Sekretär
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    British113788270001
    LEIGHTON, Katherine Jennifer
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    Sekretär
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    British110703040002
    MATHER, Melanie Gay
    2717 Luella
    77536 Deer Park
    Texas
    Usa
    Sekretär
    2717 Luella
    77536 Deer Park
    Texas
    Usa
    American92773820001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Sekretär
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British146000450001
    TORKINGTON, John Robert
    2 Barwell Close
    Reddish
    SK5 6YF Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    2 Barwell Close
    Reddish
    SK5 6YF Stockport
    Cheshire
    British35453200001
    BODDINGTON, Kenneth William
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British1343490001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Geschäftsführer
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritish61611910001
    CAMP, Glenn Bryan
    19 Hough Lane
    Gristhorpe
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Hough Lane
    Gristhorpe
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    American54147750001
    FITZGERALD, Mel Oliver
    3 Marlyns Drive
    Burpham
    GU4 7LS Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Marlyns Drive
    Burpham
    GU4 7LS Guildford
    Surrey
    United Kingdom/EnglandIrish69993790001
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    Geschäftsführer
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    British113788270001
    GARVEY, William
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    British590690001
    GARVEY, William
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    British590690001
    HARRISON, Michael
    126 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6TP Stockport
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    126 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6TP Stockport
    Cheshire
    England
    EnglandBritish86410610001
    HERBERT, John Shotton
    Michelend
    Lewes Road, Westmeston
    BN6 8RH Hassocks
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Michelend
    Lewes Road, Westmeston
    BN6 8RH Hassocks
    West Sussex
    British81675020001
    HOUSTON, John Joseph
    3 Kinmundy Avenue
    AB32 6TG Westhill
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    3 Kinmundy Avenue
    AB32 6TG Westhill
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish81041240001
    HUGHES, Emyr Tonlas
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    British40119990001
    KASH, John
    57 Aspen Drive
    FOREIGN Basking Ridge
    New Jersey
    Usa
    Geschäftsführer
    57 Aspen Drive
    FOREIGN Basking Ridge
    New Jersey
    Usa
    American9489980001
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Geschäftsführer
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    KENNEDY, Michael James
    15 Heathway
    CR3 5DN Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Heathway
    CR3 5DN Caterham
    Surrey
    British54147870002
    KRABLIN, Steven Wayne
    9619 Windrush Drive
    77379 Spring
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    9619 Windrush Drive
    77379 Spring
    Texas
    Usa
    UsaUnited States69886740001
    MATHEWSON, Lindsay Thomas
    21 Macclesfield Road
    SK17 9AH Buxton
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    21 Macclesfield Road
    SK17 9AH Buxton
    Derbyshire
    British590700001
    MOLLER, Leslie George
    12 Chester Court
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    12 Chester Court
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish63570320001
    NICHOLSON, Stephen John
    48 Wolseley Gardens
    W4 3LS London
    Geschäftsführer
    48 Wolseley Gardens
    W4 3LS London
    British3042100001
    OCONNOR, William Evans
    Gristhorpe
    19 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Gristhorpe
    19 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Us Citizen13102020001
    SPEIRS, John Garrett
    20 Dunstall Road
    Wimbledon
    SW20 0HR London
    Geschäftsführer
    20 Dunstall Road
    Wimbledon
    SW20 0HR London
    EnglandBritish428480001
    TOCHER, Judith Robertson
    Blacktop House, Blacktop
    Kingswells
    AB15 8QJ Aberdeen
    Geschäftsführer
    Blacktop House, Blacktop
    Kingswells
    AB15 8QJ Aberdeen
    United KingdomBritish82086030001
    WHITE, Philip Arthur Laxton
    15 Bedford Street
    Stockton Heath
    WA4 6LY Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Bedford Street
    Stockton Heath
    WA4 6LY Warrington
    Cheshire
    British13102030001

    Hat MONO GROUP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Juni 1988
    Geliefert am 28. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    (A) by way of third fixed charge all the property (if any) specified in the first schedule of the debenture together with all buildings and fixtures (as hereinafter defined) thereon and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in performance of such covenants; (b) by way of third fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property.
    Berechtigte Personen
    • Gallaher LTD
    Transaktionen
    • 28. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Juni 1988
    Geliefert am 16. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    1. by way of second fixed charge all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of second fixed charge: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon), rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of second fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 16. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • Hat Änderungen an der Anordnung: Ja
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Juni 1988
    Geliefert am 16. Juni 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    1. by way of first legal mortgage all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of first legal mortgage: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of first fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company as Agent for Itself & Others
    Transaktionen
    • 16. Juni 1988Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0