CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED

CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC121349
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BOTHWELL STREET PROPERTIES NO. 1 LIMITED27. Nov. 198927. Nov. 1989
    AMOBE LIMITED15. Nov. 198915. Nov. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Bericht über die Schlussversammlung der freiwilligen Liquidation

    7 Seiten4.26(Scot)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL zum 110 Queen Street Glasgow G1 3BX am 06. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Sept. 2016

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Emily Ann Mousley als Geschäftsführer am 30. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Tods Murray Llp Edinburgh Quay 133 Fountainbridge Edinburgh EH3 9AG zum 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL am 06. Jan. 2015

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Hub 3 Earl Haig Road Hillington Park Glasgow G52 4JU zum C/O Tods Murray Llp Edinburgh Quay 133 Fountainbridge Edinburgh EH3 9AG am 29. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 30. Juni 2014

    1 SeitenAA01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 29. Jan. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Emily Ann Mousley am 11. Jan. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mepc Secretaries Limited am 01. Dez. 2011

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Leonard Grose am 10. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Graham Pierce als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MEPC SECRETARIES LIMITED
    Floor Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th
    Sekretär
    Floor Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4290683
    79708020003
    GROSE, David Leonard
    Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    110
    Geschäftsführer
    Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    110
    United KingdomBritishAccountant120479020004
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Portsoken Street
    E1 8HZ London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Portsoken Street
    E1 8HZ London
    1
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    LIPSCOMB, Helen
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    Sekretär
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    British5036040002
    LIPSCOMB, Helen
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    Sekretär
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    British5036040002
    PRICE, John Dewi Brychan
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    Sekretär
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    BritishChartered Secy3041640002
    WOOLLEY, Roderic Harry
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    Sekretär
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    British1017530003
    MACROBERTS (SOLICITORS)
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Sekretär
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    717590001
    ANDERSON, William Wallace
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    Geschäftsführer
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    EnglandBritishChartered Accountant2894560001
    ARMSTRONG, James
    Olde Tyles
    Camp Road
    SL9 7PE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Olde Tyles
    Camp Road
    SL9 7PE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishAccountant41035300001
    BECKWITH, John Lionel
    6 Lichfield Road
    Kew
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Lichfield Road
    Kew
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    BritishC.A.1017520001
    BETHUNE, Hamish William
    Glencairn
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Glencairn
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector1198020001
    BOYD, James Adams
    Sleepers
    Station Road
    EH41 4QL Gifford
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Sleepers
    Station Road
    EH41 4QL Gifford
    East Lothian
    BritishCorporate Financier39891810001
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant3769730001
    DARROCH, Christopher
    12 Bogton Avenue
    G44 3JJ Muirend
    Glasgow
    Geschäftsführer
    12 Bogton Avenue
    G44 3JJ Muirend
    Glasgow
    BritishChartered Surveyor81530460001
    DAVIDSON, Gavin Arthur
    3 Westfield Road
    SL6 7AU Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Westfield Road
    SL6 7AU Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Surveyor59873500003
    EDMONDSON, Grant Anthony Hird
    47 Dinmont Road
    G41 3UJ Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    47 Dinmont Road
    G41 3UJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishChartered Surveyor98404790001
    EXLEY, Richard John
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    BritishChartered Surveyor50191130002
    GAYNOR, Paul
    26 Wentworth Drive
    Usworth
    NE37 1PX Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    26 Wentworth Drive
    Usworth
    NE37 1PX Washington
    Tyne & Wear
    BritishCertified Accountant9385530001
    HALL, Margaret Mcarthur
    11 Dargarvel Avenue
    G41 5LU Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    11 Dargarvel Avenue
    G41 5LU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishSolicitor492360001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor33048780001
    LYLE, David Angus
    Ravelston
    Glencairn Road
    PA13 4NJ Kilmacolm
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Ravelston
    Glencairn Road
    PA13 4NJ Kilmacolm
    Renfrewshire
    BritishSolicitor & Chartered Secretar127450001
    MCDERMOTT, Michael Edward
    120 Bothwell Street
    G2 7JP Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    120 Bothwell Street
    G2 7JP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishSolicitor392900001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Geschäftsführer
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    BritishC.A77781180001
    MCSHERRY, Alan Cameron
    27 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QQ Glasgow
    Geschäftsführer
    27 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QQ Glasgow
    ScotlandBritishChartered Surveyor37891470001
    MOUSLEY, Emily Ann
    Grand Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BS London
    55
    England
    Geschäftsführer
    Grand Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BS London
    55
    England
    EnglandBritishChartered Accountant155262770003
    PIERCE, Graham Charles
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    Geschäftsführer
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    United KingdomUkAccoutant123665160001
    PRINGLE, Keith Sutherland
    16 Corsbie Grove
    DG8 6JE Newton Stewart
    Wigtownshire
    Geschäftsführer
    16 Corsbie Grove
    DG8 6JE Newton Stewart
    Wigtownshire
    BritishChartered Surveyor1374510005
    QUINCE, Roger Edward
    Timber Hills
    Rede Road Whepstead
    IP29 4SR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Timber Hills
    Rede Road Whepstead
    IP29 4SR Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritishEconomist92937100001
    RANKIN, Robert Craig Mcpherson
    Dunbarney House
    Bridge Of Earn
    PH2 9EE Perth
    Geschäftsführer
    Dunbarney House
    Bridge Of Earn
    PH2 9EE Perth
    BritishExec.Director35826120001
    RUSH, Anthony John
    Craigend
    Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Craigend
    Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandBritishDirector526850001
    RUTHERFORD, William Lindsay
    Ham Green Cottage
    Ham
    SN8 3QR Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Ham Green Cottage
    Ham
    SN8 3QR Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector48416720001
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    BritishChartered Surveyor39476870001
    SILLS, Christopher Mark
    45 Lady Place
    OX14 4FB Sutton Courtenay
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    45 Lady Place
    OX14 4FB Sutton Courtenay
    Oxfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor70646860002
    SINCLAIR, Donald Templeton
    6 Dunure Drive
    Newton Mearns
    G77 5TH Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    6 Dunure Drive
    Newton Mearns
    G77 5TH Glasgow
    Lanarkshire
    BritishSolicitor127420001

    Hat CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Bond & floating charge
    Erstellt am 01. Apr. 1994
    Geliefert am 19. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (410)
    • 12. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts
    Erstellt am 30. Juli 1993
    Geliefert am 05. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies which are received or receivable by the company or its agents in connection with the lease or licence of any of the properties.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent for Itself and Others
    Transaktionen
    • 05. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (410)
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts
    Erstellt am 05. Juli 1993
    Geliefert am 15. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies which are received or receivable by the company or its agents in connection with the lease or licence of any of the properties or any part thereof (such monies to include, without limitation, all rental monies, licence fees an all other sums in connection with the properties (including any rental or licence fees increased pursuant to the provisions of the leases) and interest (if any) in respect of overdue rent).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent for Itself and Others
    Transaktionen
    • 15. Juli 1993Registrierung einer Belastung (410)
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts
    Erstellt am 17. Juni 1993
    Geliefert am 02. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and others
    Kurze Angaben
    All monies receivable by the company in connection with leases. See companies house microfiche.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 02. Juli 1993Registrierung einer Belastung (410)
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts
    Erstellt am 17. Feb. 1992
    Geliefert am 27. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received in connection with the lease of the properties.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Co of the Bank of Scotland Foe Itself and as Agent for the Banks
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1992Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 03. Juni 1991
    Geliefert am 11. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due, or to become due by company and/or caledonian land PLC
    Kurze Angaben
    Subjects k/a 51 watt road hillington glasgow title no ren 25594.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agentfor the Bank
    Transaktionen
    • 11. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 23. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 21. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 15. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of license.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 11. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 08. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 20. Dez. 1990
    Geliefert am 07. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 19. Dez. 1990
    Geliefert am 07. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 18. Dez. 1990
    Geliefert am 07. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received or receivable by the company or its agents in connection with the lease of licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Assignation of book debts (rents)
    Erstellt am 12. Dez. 1990
    Geliefert am 12. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All monies received by the company or its agents in connection with the lease or licence.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 12. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 12.45 acres and forming yorker industrial estate glasgow.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 7.79 acres and forming righead industrial estate bellshill.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subject comprising 141.227 acres, 0.78 acres, 2 acres, 0.17 acres forming newhouse industrial estate, lanarkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subject comprising 5.682 acres, 1.03 acres, forming martyn street industrail estate airdrie.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subject comprising 27.605 acres, 13.171 acres, 2.976 acres forming carfin industrail estate lanarkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 47.483 acres forming thornliebank industrial estate glasgow.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 4 acres and 2 acres, 2 roods and 7 poles, 770 sq yards, 8,860 sq yds, 20,599 sq yds, 400 sq yrds forming germiston industrial estate glasgow.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 7.085 acres, 3.796 acres at shand mills, sanquhar.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 86 acres, 0.050 acres, 0.24 hectares subjects under title no dmb 6314 forming clydebank business clydebank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 06. Aug. 1990
    Geliefert am 23. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due by the company and/or another
    Kurze Angaben
    Subjects comprising 31.726 acres 8.646 acres, 21.6 acres, 1.738 acres subject under title no lan 3716 forming blantyre industrial estate lanarkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)

    Hat CALEDONIAN LAND PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Dez. 2017Aufgelöst am
    29. Sept. 2016Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anmerkungenscottish-insolvency-info

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0