MCSENCE HEATWISE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMCSENCE HEATWISE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC131570
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MCSENCE HEATWISE LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich MCSENCE HEATWISE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mcsence Business Enterprise Park
    32 Sycamore Road
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCSENCE HEATWISE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für MCSENCE HEATWISE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    5 SeitenDS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Juli 2010

    Kapitalaufstellung am 09. Juli 2010

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Ernennung von Mr David Caven Maxwell als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christopher Harris als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Colin Beattie Moreland als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr James Murphy als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Brian Tannerhill als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Shaw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    10 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten410(Scot)

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MCSENCE HEATWISE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PATERSON, Alan
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    Sekretär
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    British97442470003
    EDMONDS, David William
    18 Stone Avenue
    Mayfield
    EH22 5PD Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    18 Stone Avenue
    Mayfield
    EH22 5PD Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish62958530001
    HARRIS, Christopher
    Ashley Road
    EH11 1RP Edinburgh
    15
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    EH11 1RP Edinburgh
    15
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish50716750001
    HOGG, Michael
    29a Stone Place
    Mayfield
    EH22 5PW Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    29a Stone Place
    Mayfield
    EH22 5PW Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish68724210001
    HOGG, Robert
    44 Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5DZ Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    44 Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5DZ Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish46111230003
    MAXWELL, David Caven
    Galashiels Road
    TD1 2RE Stow
    149
    Scottish Borders
    Scotland
    Geschäftsführer
    Galashiels Road
    TD1 2RE Stow
    149
    Scottish Borders
    Scotland
    United KingdomBritish149458350001
    MORELAND, Colin Beattie
    Hillview Terrace
    EH12 8RA Edinburgh
    3
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Hillview Terrace
    EH12 8RA Edinburgh
    3
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish102920570001
    MURPHY, James
    Kippielaw Drive
    EH22 4HT Dalkeith
    11
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Kippielaw Drive
    EH22 4HT Dalkeith
    11
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish101169690001
    PATERSON, Alan
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    Geschäftsführer
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    United KingdomBritish97442470003
    PATERSON, Scott
    80 Denholm Avenue
    EH21 6TY Musselburgh
    East Lothian
    Geschäftsführer
    80 Denholm Avenue
    EH21 6TY Musselburgh
    East Lothian
    United KingdomBritish126689700001
    RAMSAY, Barbara
    30 Leighton Crescent
    Easthouses
    EH22 4DX Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    30 Leighton Crescent
    Easthouses
    EH22 4DX Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish19100140001
    RODGER, Williamina Shaw
    97 Oak Place
    Mayfield
    EH22 5NB Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    97 Oak Place
    Mayfield
    EH22 5NB Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish46111510001
    SHAW, Albert
    15 Blackcot Avenue
    EH22 5RY Mayfield
    Midlothian
    Geschäftsführer
    15 Blackcot Avenue
    EH22 5RY Mayfield
    Midlothian
    United KingdomBritish97433350001
    BOWIE, Patricia
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Sekretär
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Scottish46111440001
    CAUSER, Allison
    18 Sherwood View
    EH19 3NQ Bonnyrigg
    Midlothian
    Sekretär
    18 Sherwood View
    EH19 3NQ Bonnyrigg
    Midlothian
    British97433420001
    CRAIG, Julie
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    Sekretär
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    British68971180002
    HOGG, Peter
    2 Pinewood View
    Mayfield
    EH22 5JD Dalkeith
    Midlothian
    Sekretär
    2 Pinewood View
    Mayfield
    EH22 5JD Dalkeith
    Midlothian
    British1390590001
    TANNERHILL, Brian
    6 Camp Rd
    Mayfield
    EH22 5HE Dalkeith
    Midlothian
    Sekretär
    6 Camp Rd
    Mayfield
    EH22 5HE Dalkeith
    Midlothian
    British34606640001
    BOWIE, Patricia
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish46111440001
    BOYLE, Peter
    57 Waugh Path
    EH19 3QE Bonnyrigg
    Midlothian
    Geschäftsführer
    57 Waugh Path
    EH19 3QE Bonnyrigg
    Midlothian
    British87849850001
    CAMPBELL, Thomas Hunter
    1b Lawfield Road
    Mayfield
    EH22 5BA Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    1b Lawfield Road
    Mayfield
    EH22 5BA Dalkeith
    Midlothian
    British44416520001
    CHRISTISON, Lynda
    4 Rowantree Road
    Mayfield
    EH22 5ER Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    4 Rowantree Road
    Mayfield
    EH22 5ER Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish68724340001
    CRAIG, Julie
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    Geschäftsführer
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    British68971180002
    CRAWFORD, James
    29 Lawfield Road
    Mayfield
    EH22 5AQ Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    29 Lawfield Road
    Mayfield
    EH22 5AQ Dalkeith
    Midlothian
    British44385050001
    GIBBON, Philip
    2 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Geschäftsführer
    2 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British44385030002
    GRANT, Terrence John
    26f Laurelbank Road
    Mayfield
    EH22 5HW Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    26f Laurelbank Road
    Mayfield
    EH22 5HW Dalkeith
    Midlothian
    British68970740001
    HOGG, James Burns
    20 David Scott Avenue
    EH22 5BU Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    20 David Scott Avenue
    EH22 5BU Dalkeith
    Midlothian
    British87998960001
    HOGG, Peter
    2 Pinewood View
    Mayfield
    EH22 5JD Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    2 Pinewood View
    Mayfield
    EH22 5JD Dalkeith
    Midlothian
    British1390590001
    KELLY, Frances Cunningham
    9 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HN Dalkeith
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    9 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HN Dalkeith
    Midlothian
    Scotland
    British25947200001
    LOTHIAN, Brian
    63 Fifth Street
    Newtongrange
    EH22 4PL Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    63 Fifth Street
    Newtongrange
    EH22 4PL Dalkeith
    Midlothian
    British1306690001
    MCGUIRE, John
    3 Buckie Road
    Mayfield
    EH22 5EP Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Buckie Road
    Mayfield
    EH22 5EP Dalkeith
    Midlothian
    British19100030001
    NEALE, Winifred Janette Reid Macintyre Ray
    30 Poplar Street
    Mayfield
    EH22 5LW Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    30 Poplar Street
    Mayfield
    EH22 5LW Dalkeith
    Midlothian
    British1390570001
    ONEILL, Patrick
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish19100080001
    ONEILL, Patrick
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish19100080001
    SHAW, Christopher John
    Glencairn
    13 Waverley Road Eskbank
    EH22 3DG Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Glencairn
    13 Waverley Road Eskbank
    EH22 3DG Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish80086590003

    Hat MCSENCE HEATWISE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Bond & floating charge
    Erstellt am 02. Apr. 2008
    Geliefert am 09. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (410)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0