MCSENCE HEATWISE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MCSENCE HEATWISE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC131570 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MCSENCE HEATWISE LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich MCSENCE HEATWISE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Mcsence Business Enterprise Park 32 Sycamore Road EH22 5TA Mayfield, Dalkeith Midlothian |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCSENCE HEATWISE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MCSENCE HEATWISE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 5 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr David Caven Maxwell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Harris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Beattie Moreland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Murphy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Tannerhill als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Shaw als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 410(Scot) | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MCSENCE HEATWISE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATERSON, Alan | Sekretär | 32 Castle Avenue EH32 0ES Port Seton | British | 97442470003 | ||||||
| EDMONDS, David William | Geschäftsführer | 18 Stone Avenue Mayfield EH22 5PD Dalkeith Midlothian | United Kingdom | British | 62958530001 | |||||
| HARRIS, Christopher | Geschäftsführer | Ashley Road EH11 1RP Edinburgh 15 Midlothian Scotland | Scotland | British | 50716750001 | |||||
| HOGG, Michael | Geschäftsführer | 29a Stone Place Mayfield EH22 5PW Dalkeith Midlothian | United Kingdom | British | 68724210001 | |||||
| HOGG, Robert | Geschäftsführer | 44 Bogwood Road Mayfield EH22 5DZ Dalkeith Midlothian | Scotland | Scottish | 46111230003 | |||||
| MAXWELL, David Caven | Geschäftsführer | Galashiels Road TD1 2RE Stow 149 Scottish Borders Scotland | United Kingdom | British | 149458350001 | |||||
| MORELAND, Colin Beattie | Geschäftsführer | Hillview Terrace EH12 8RA Edinburgh 3 Midlothian Scotland | Scotland | British | 102920570001 | |||||
| MURPHY, James | Geschäftsführer | Kippielaw Drive EH22 4HT Dalkeith 11 Midlothian Scotland | United Kingdom | British | 101169690001 | |||||
| PATERSON, Alan | Geschäftsführer | 32 Castle Avenue EH32 0ES Port Seton | United Kingdom | British | 97442470003 | |||||
| PATERSON, Scott | Geschäftsführer | 80 Denholm Avenue EH21 6TY Musselburgh East Lothian | United Kingdom | British | 126689700001 | |||||
| RAMSAY, Barbara | Geschäftsführer | 30 Leighton Crescent Easthouses EH22 4DX Dalkeith Midlothian | United Kingdom | British | 19100140001 | |||||
| RODGER, Williamina Shaw | Geschäftsführer | 97 Oak Place Mayfield EH22 5NB Dalkeith Midlothian | United Kingdom | British | 46111510001 | |||||
| SHAW, Albert | Geschäftsführer | 15 Blackcot Avenue EH22 5RY Mayfield Midlothian | United Kingdom | British | 97433350001 | |||||
| BOWIE, Patricia | Sekretär | 54 Larch Crescent Mayfield EH22 5ND Dalkeith Midlothian | Scottish | 46111440001 | ||||||
| CAUSER, Allison | Sekretär | 18 Sherwood View EH19 3NQ Bonnyrigg Midlothian | British | 97433420001 | ||||||
| CRAIG, Julie | Sekretär | 3 Hillside Drive TD1 2HN Galashiels Selkirkshire | British | 68971180002 | ||||||
| HOGG, Peter | Sekretär | 2 Pinewood View Mayfield EH22 5JD Dalkeith Midlothian | British | 1390590001 | ||||||
| TANNERHILL, Brian | Sekretär | 6 Camp Rd Mayfield EH22 5HE Dalkeith Midlothian | British | 34606640001 | ||||||
| BOWIE, Patricia | Geschäftsführer | 54 Larch Crescent Mayfield EH22 5ND Dalkeith Midlothian | Scotland | Scottish | 46111440001 | |||||
| BOYLE, Peter | Geschäftsführer | 57 Waugh Path EH19 3QE Bonnyrigg Midlothian | British | 87849850001 | ||||||
| CAMPBELL, Thomas Hunter | Geschäftsführer | 1b Lawfield Road Mayfield EH22 5BA Dalkeith Midlothian | British | 44416520001 | ||||||
| CHRISTISON, Lynda | Geschäftsführer | 4 Rowantree Road Mayfield EH22 5ER Dalkeith Midlothian | Scotland | Scottish | 68724340001 | |||||
| CRAIG, Julie | Geschäftsführer | 3 Hillside Drive TD1 2HN Galashiels Selkirkshire | British | 68971180002 | ||||||
| CRAWFORD, James | Geschäftsführer | 29 Lawfield Road Mayfield EH22 5AQ Dalkeith Midlothian | British | 44385050001 | ||||||
| GIBBON, Philip | Geschäftsführer | 2 King Malcolm Close EH10 7JB Edinburgh | British | 44385030002 | ||||||
| GRANT, Terrence John | Geschäftsführer | 26f Laurelbank Road Mayfield EH22 5HW Dalkeith Midlothian | British | 68970740001 | ||||||
| HOGG, James Burns | Geschäftsführer | 20 David Scott Avenue EH22 5BU Dalkeith Midlothian | British | 87998960001 | ||||||
| HOGG, Peter | Geschäftsführer | 2 Pinewood View Mayfield EH22 5JD Dalkeith Midlothian | British | 1390590001 | ||||||
| KELLY, Frances Cunningham | Geschäftsführer | 9 Darcy Road Mayfield EH22 5HN Dalkeith Midlothian Scotland | British | 25947200001 | ||||||
| LOTHIAN, Brian | Geschäftsführer | 63 Fifth Street Newtongrange EH22 4PL Dalkeith Midlothian | British | 1306690001 | ||||||
| MCGUIRE, John | Geschäftsführer | 3 Buckie Road Mayfield EH22 5EP Dalkeith Midlothian | British | 19100030001 | ||||||
| NEALE, Winifred Janette Reid Macintyre Ray | Geschäftsführer | 30 Poplar Street Mayfield EH22 5LW Dalkeith Midlothian | British | 1390570001 | ||||||
| ONEILL, Patrick | Geschäftsführer | 41 Darcy Road Mayfield EH22 5HL Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 19100080001 | |||||
| ONEILL, Patrick | Geschäftsführer | 41 Darcy Road Mayfield EH22 5HL Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 19100080001 | |||||
| SHAW, Christopher John | Geschäftsführer | Glencairn 13 Waverley Road Eskbank EH22 3DG Dalkeith Midlothian | Scotland | British | 80086590003 |
Hat MCSENCE HEATWISE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Erstellt am 02. Apr. 2008 Geliefert am 09. Apr. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0