WESLO HOUSING MANAGEMENT
Überblick
| Unternehmensname | WESLO HOUSING MANAGEMENT |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | SC140597 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WESLO HOUSING MANAGEMENT?
- Verwaltung von Bewohnerimmobilien (98000) / Private Haushalte als Arbeitgeber; nicht weiter differenzierte Erwerbstätigkeiten von privaten Haushalten für eigene Zwecke
Wo befindet sich WESLO HOUSING MANAGEMENT?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESLO HOUSING MANAGEMENT?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 28. Feb. 2021 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Nov. 2021 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Feb. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WESLO HOUSING MANAGEMENT?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Form b convert to registered society | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lynsey Sarah Breen als Geschäftsführer am 24. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Margaret Stewart Mcintyre als Direktor am 28. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Caroline Joanna Dunn Kennedy als Direktor am 28. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2020 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kenneth William Mackenzie Tudhope als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alistair James Booth als Direktor am 27. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lynsey Sarah Breen als Direktor am 27. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diana Helen Maclean als Geschäftsführer am 27. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kenneth Redmond als Geschäftsführer am 27. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Eileen Porter als Direktor am 25. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Matthew Torrance als Geschäftsführer am 10. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joyce Cameron als Geschäftsführer am 06. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Diana Helen Maclean am 21. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lorraine Paterson als Geschäftsführer am 15. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Andrew Bruce als Geschäftsführer am 13. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Douglas William Drummond als Geschäftsführer am 31. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth William Mackenzie Tudhope als Direktor am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lorraine Paterson als Direktor am 17. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2019 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Redmond als Direktor am 17. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Joyce Cameron als Direktor am 17. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WESLO HOUSING MANAGEMENT?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T C YOUNG LLP | Sekretär | West George Street G2 1BA Glasgow Merchants House, 7 Scotland | 92309420002 | |||||||||||
| BOOTH, Alistair James | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | Scottish | 152845230001 | |||||||||
| CASKIE, Donald Ian | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 259479260001 | |||||||||
| DEWAR, Katherine Margaret | Geschäftsführer | North Bridge Street EH48 4PP Bathgate 66 West Lothian | Scotland | British | 141834740001 | |||||||||
| FINNIE, George | Geschäftsführer | High Street PA12 4AB Lochwinnoch 29 Scotland | Scotland | British | 240422640001 | |||||||||
| GREEN, James | Geschäftsführer | Chestnut Grove Stenhousemuir FK5 4DU Larbert 51 Scotland | United Kingdom | British | 240423000001 | |||||||||
| HIGGINS, Brenda | Geschäftsführer | North Bridge Street EH48 4PP Bathgate 66 West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 175534450001 | |||||||||
| KENNEDY, Caroline Joanna Dunn | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 259191300001 | |||||||||
| MCINTYRE, Margaret Stewart | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 137697520001 | |||||||||
| PORTER, Eileen | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 124710570002 | |||||||||
| ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower Midlothian |
| 665080009 | ||||||||||
| HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 19 Ainslie Place EH3 6AU Edinburgh | 900006190001 | |||||||||||
| HENDERSON BOYD JACKSON W.S. | Sekretär | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Midlothian | 38350020002 | |||||||||||
| ANDERSON, Frank, Councillor | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 32218490001 | |||||||||
| BALFOUR, Andrew | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | Scottish | 114443900001 | |||||||||
| BALFOUR, Andrew | Geschäftsführer | 8 Alexander Drive Dedridge EH54 6DB Livingston West Lothian | Scotland | Scottish | 114443900001 | |||||||||
| BOW, Alex | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 137697330002 | |||||||||
| BREEN, Lynsey Sarah | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 261855190001 | |||||||||
| BROWN, Lorna | Geschäftsführer | 71 Parkhead Gardens EH55 8BD West Calder West Lothian Scotland | British | 27169470001 | ||||||||||
| BRUCE, Michael Andrew | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | Scottish | 28068610002 | |||||||||
| CAMERON, Joyce | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | Scottish | 260845440001 | |||||||||
| CLELAND, Richard | Geschäftsführer | 11 The Avenue Whitburn EH47 0DD Bathgate West Lothian | British | 64426880001 | ||||||||||
| CONSTABLE, John | Geschäftsführer | 46 Kinneil Drive EH51 0LY Boness West Lothian | British | 65909660001 | ||||||||||
| CROZIER, Michael Stewart | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 28068620002 | |||||||||
| DALTON, Elaine | Geschäftsführer | 17 Staunton Rise EH54 6PB Livingston West Lothian | British | 64426990001 | ||||||||||
| DALYELL, Kathleen | Geschäftsführer | The Binns EH49 7NA Linlithgow West Lothian | British | 39408630001 | ||||||||||
| DRUMMOND, Douglas William | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 28068590002 | |||||||||
| EDWARDS, Carole | Geschäftsführer | 159 Harburn Drive EH55 8AW West Calder West Lothian | British | 34366520001 | ||||||||||
| GOLDIE, Gerald, J.P. | Geschäftsführer | 66 North Bridge Street Bathgate EH48 4PP West Lothian | Scotland | British | 70302290001 | |||||||||
| GRAHAM, Andrew | Geschäftsführer | 55 Pennelton Place EH51 0PD Boness West Lothian | British | 91670620001 | ||||||||||
| HARVEY, Patricia Margaret | Geschäftsführer | 12 Forth Street FK3 8LE Grangemouth Stirlingshire | British | 114443950001 | ||||||||||
| ILLIDGE, Albert | Geschäftsführer | 21 Liddle Drive EH51 0PA Boness West Lothian | British | 71489660001 | ||||||||||
| JACKSON, Alice Ann | Geschäftsführer | North Bridge Street EH48 4PP Bathgate 66 West Lothian | Scotland | British | 56970002 | |||||||||
| JOHNSTONE, Evelyn Dobie | Geschäftsführer | 16 Glen Crescent Deans EH54 8BW Livingston West Lothian | Scotland | British | 71489590001 | |||||||||
| LEE, Robert | Geschäftsführer | 157 Lanrigg Road Fauldhouse EH47 9JJ Bathgate West Lothian | British | 36585760001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für WESLO HOUSING MANAGEMENT?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 08. Okt. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat WESLO HOUSING MANAGEMENT Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 04. Dez. 2018 Geliefert am 06. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects registered under the following title numbers:. (1) WLN1259, (2) WLN1268, (3) WLN39001, and (4) WLN47445. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Nov. 2017 Geliefert am 28. Nov. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole the dwellinghouse known as 91 whiteside court, bathgate, EH48 2TP registered in the land register of scotland under title number WLN47447. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. März 2015 Geliefert am 02. Apr. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Subjects situated at 5 union road, whitburn EH47 0AW (title number WLN3685) and others. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. März 2015 Geliefert am 02. Apr. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Subjects situated at bathville court, armadale (title number WLN22645) and others. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. März 2015 Geliefert am 02. Apr. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Subjects situated at mansefield, east calder and others. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2013 Geliefert am 30. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 8, yule terrace, blackburn, EH47 7HJ, title number WLN45839;. 51, vale of bonnyview, falkirk, FK4 1BN, title number STG47141;. 90, benhar road, shotts, ML7 5EP, title number LAN153954;. 2, elm square, whitburn, EH47 8NE, title number WLN40839;. 3, yule terrace, blackburn, EH47 7HJ, title number WLN10740;. 66, bankton drive, livingston, EH54 9EJ, title number MID89717;. 25, burns place, shotts, ML7 4LQ, title number LAN132180;. 9, fendoch road, falkirk, FK3 9HB, title number STG7875;. 141, cloglands, forth, ML11 8EH, title number LAN193900;. 13, northfield avenue, shotts, ML7 5HR, title number LAN177326;. 33, avondale drive, armadale, EH48 3HH, title number WLN23452;. 64, carradale avenue, falkirk, FK1 4AF, title number STG4106;. 11, rowan drive, bonnybridge, FK4 1TB, title number STG32605;. 38, carledubs crescent, uphall, EH52 6TQ, title number WLN19126;. 8, tarbert place, carluke, WL8 4JH, title number LAN133658;. 40, woodlands avenue, carluke, ML8 5JL, title number LAN57187;. 15, mansefield, east calder, EH53 0JB, title number MID143354;. 51, dochart crescent, falkirk, FK2 0RE, title number STG67280;. 28, murdostoun crescent, harthill, ML7 5SR, title number LAN129352;. 19, crossgreen place, uphall, EH52 6TD, title number WLN40693;. 63, polmont park, falkirk, FK2 0XU, title number STG58212;. 16, beech crescent, denny, FK6 6LJ, title number STG54095;. 140, lea rig, forth, ML11 8EQ, title number LAN185223;. 23, culmore place, hallglen, FK1 2PP, title number STG56234;. 14, roxburgh place, stenhousemuir, FK5 4UE, title number STG5942;. 98, gardner crescent, whitburn, EH47 0NR, title number WLN4062;. 70, liddle drive, bo'ness, EH51 0PB, title number WLN1591;. 9B, bank street, falkirk, FK1 1NB, title number STG29590;. 4, sunnyside, stoneyburn, EH47 8BZ, title number WLN7291;. 4, gowan avenue, falkirk, FK2 7HL, title number STG33841;. 19, watling drive, falkirk, FK1 4QD, title number STG4761;. 10, paul drive, falkirk, FK2 8LA, title number STG65123;. 128, south street, armadale, EH48 3JU, title number WLN7560;. 58, ladeside road, blackburn, EH47 7JR, title number WLN15586;. 19, greig crescent, armadale, EH48 2PS, title number WLN7147;. 46, cultrig drive, whitburn, EH47 8HP, title number WLN17901;. 7, cardross road, broxburn, EH52 6HU, title number WLN2098;. 14, baillie street, whitburn, EH47 0ER, title number WLN15608;. 62, riverside, newbridge, EH28 8SU, title number MID55827;. 11, dick gardens, whitburn, EH47 0BN, title number WLN35735;. 174, campsrigg, livingston, EH54 8PF, title number WLN10721;. 34, fells rigg, livingston, EH54 8PA, title number WLN18036;. 41, kennard street, falkirk, FK2 9EH, title number STG33791;. 9, cadzow avenue, bo'ness, EH51 9BS, title number WLN10878;. 21, curran crescent, broxburn, EH52 5RY, title number WLN20226;. 18, blaeberryhill road, whitburn, EH47 8LB, title number WLN20831;. 31, ellismuir street, coatbridge, ML5 5BH, title number LAN132819;. 109, park view, fauldhouse, EH47 9LD, title number WLN25917;. 123, barclay way, livingston, EH54 8HA, title number WLN14260;. 6, lenzie avenue, livingston, EH54 8NP, title number WLN15555;. 109, philip avenue, bathgate, EH48 1LZ, title number WLN7666;. 8, union court, bo'ness, EH51 9AJ, title number WLN31759;. 51, fallas place, fauldhouse, EH47 9BZ, title number WLN1702;. 167, muirhall terrace, shotts, ML7 4LX, title number LAN135666;. 32, kirkbrae, longridge, EH47 8AH, title number LN13040;. 84, glenalmond, whitburn, EH47 8NS, title number WLN7037;. 129, overton crescent, denny, FK6 5BA, title number STG2203;. 44, dalderse avenue, falkirk, FK2 7EG, title number STG8007;. 43, townhead gardens, whitburn, EH47 8JL, title number WLN16347; and. 4, union road, whitburn, EH47 0AW, title number WLN11117. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2013 Geliefert am 30. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The following subjects recorded in the register of sasines and described in the schedule (as defined in the instrument evidencing the charge accompanying this form MR01);. 43 sedgebank, livinsgton, EH54 6HE, midlothian;. 90 sedgebank, livingston, EH54 6HD, midlothian;. 45 falconer rise, livingston, EH54 6JE, midlothian;. 23 nigel rise, livingston, EH54 6LT, midlothian;. 47 norman rise, livingston, EH54 6LY, midlothian; and. 61 everard rise, livingston, EH54 6JD, midlothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2013 Geliefert am 30. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects known as 1-13 (inclusive) and 15 academy view whitburn lying on the northeast side of ellen street, whitburn registered in the land register of scotland under title number WLN39780. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2013 Geliefert am 30. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects known as 1-14 (inclusive) edward avenue, bathgate erected on the area of ground extending to 4458 square metres at charles crescent boghall, bathgate registered in the land register of scotland under title number WLN39779. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2013 Geliefert am 30. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole that area or piece of ground at mooreland gardens, addiewell, west calder with the dwellinghouses erected thereon being (one) that area of ground extending to seventy nine decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure lying in the parish of west calder and county of midlothian (formerly edinburgh) described in, disponed by and delineated and shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to disposition by the county council of the county of midlothian in favour of scottish special housing association dated seventh and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on sixteenth both days of july nineteen hundred and forty eight; and (two) that area of ground extending to ninety eight decimal or one hundredth parts of an acre or thereby imperial standard measure lying in the said parish and county described in, disponed by and delineated and shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to disposition by david dick tod and another in favour of scottish special housing association dated sixteenth and recorded in the said division of the general register of sasines on twenty sixth both days of july nineteen hundred and forty eight under exception of (first) all and whole the subjects known as and forming 49 mooreland gardens, aforesaid being the subjects more particularly described in and disponed by feu disposition by scottish homes in favour of james toner and rita mary toner dated 28 november 1991 and recorded in the said division of the general register of sasines on 22 may 1992; (second) all and whole the subjects known as 62 mooreland gardens, aforesaid being the subjects more particularly described in and disponed by feu disposition by scottish homes in favour of nora duffy and theresa anne duffy dated 23 september 1993 and recorded in the said division of the general register of sasines on 4 october 1993; (third) all and whole the subjects known as 58 mooreland gardens, aforesaid being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID57927; (fourth) all and whole the subjects known as 47 mooreland gardens aforesaid registered under title number MID119231; and (fifth) all and whole the subjects known as 60 mooreland gardens, aforesaid being the subjects registered in the land register under title number MID126074. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 05. Dez. 2012 Geliefert am 24. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects situated at 1,2,3,5,6,7,8,9,12 sheephousehill lane, fauldhouse. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 05. Dez. 2012 Geliefert am 24. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects situated at 67 howletnest road, airdrie. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 03. Dez. 2012 Geliefert am 24. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects situated at 24 limebank park, east calder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 03. Dez. 2012 Geliefert am 24. Dez. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects situated at 3,6,9,11,14,16,18,19 and 20 cunnigar gardens, midcalder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 96 gardner crescent, whitburn, title number WLN25694. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 55 whitelaw drive, title number WLN11326. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 14 robertson avenue, bathgate, title number WLN4299. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 87 birkenshaw way, bathgate, title number WLN22199. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 33 woodend walk, armadale, title number WLN22719. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 159 woodend walk, armadale, title number WLN26788. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 27 woodend walk, armadale, title number WLN6154. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 137 birkenshaw way, bathgate, title number WLN20238. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 23 loanfoot crescent, broxburn, title number WLN22428. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 5 kelso street, broxburn, title number WLN19286. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 12. Juli 2011 Geliefert am 28. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Subjects at 122 gardner crescent, whitburn, title number WLN8330. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0