PROSPECTRE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PROSPECTRE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | SC145280 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROSPECTRE LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich PROSPECTRE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh Scotland |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROSPECTRE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HARMONIUM LIMITED | 02. Juli 1993 | 02. Juli 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROSPECTRE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROSPECTRE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House 60 Maxwell Road Glasgow G41 1PR am 14. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 38 Seiten | MG01s | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG03s | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Charles Gale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Gillian Elizabeth James als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderungen an der schwebenden Belastung 10 | 42 Seiten | 466(Scot) | ||||||||||
Änderungen an der schwebenden Belastung 11 | 42 Seiten | 466(Scot) | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROSPECTRE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | 151396130001 | |||||||
GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | England | British | Accountant | 96956740001 | ||||
MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 47785600002 | ||||
JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
LUBASCH, Richard Joel | Sekretär | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | Solicitor | 47785600002 | |||||
BURNETT & REID | Sekretär | 15 Golden Square AB10 1WF Aberdeen | 39027620001 | |||||||
VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | Chief Operations Officer | 59445920002 | ||||
GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | Accountant | 96956740001 | ||||
GREGG, John Francis | Geschäftsführer | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | Chief Financial Officer | 75381740001 | |||||
KELHAM, David William | Geschäftsführer | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | Finance Director | 87146390001 | ||||
KNAPP, James Barclay | Geschäftsführer | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | Chief Executive Officer | 79688880001 | |||||
LEVIE, David Stuart Craigen | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 15 Golden Square AB9 1JF Aberdeen | British | 900005070001 | ||||||
MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | Solicitor | 47785600002 | ||||
MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | Solicitor | 47785600002 | ||||
MCKELLAR, Ronald Alexander | Geschäftsführer | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | Finance Director | 7345780001 | |||||
MCLEOD, Allan Macrae | Geschäftsführer | 19 Kings Gate AB15 4EL Aberdeen | British | Managing Director | 35637260002 | |||||
OKAS, John Anthony | Geschäftsführer | Dipley Springs, Dipley Common RG27 8JS Hook Hampshire | England | British | Director | 112280340001 | ||||
RICHTER, Bret | Geschäftsführer | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | Company Director | 86830760001 | |||||
ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | Treasurer | 145824690001 | |||||
ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | Finance Director | 20168110001 | ||||
SCHUBERT, Scott Elliott | Geschäftsführer | 9 William Street House William Street SW1X 9HH London | American | Chief Financial Officer | 89618040001 | |||||
WOOD, Leigh | Geschäftsführer | The Priory 10 Hambledon Park Hambledon GU8 4ER Godalming Surrey | American | Chief Operating Officer | 53880530001 | |||||
VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
Hat PROSPECTRE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 09. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 08. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 02. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 28. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 28. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 04. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Floating charge | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 04. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Floating charge | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Floating charge | Erstellt am 13. Apr. 2004 Geliefert am 30. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due under any or all of the finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over assets - see mortgage document for full details. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 03. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations as contained in the finance documents | |
Kurze Angaben Legal mortgage over land; fixed charges over assets; floating charge over same. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 21. Feb. 2001 Geliefert am 06. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations pursuant to the finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over assets..see ch microfiche for full details. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 17. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0