GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED

GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC147142
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 Duncan Street
    EH9 1SZ Edinburgh
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CATLIN EPSILON LIMITED29. Mai 200729. Mai 2007
    WELLINGTON EPSILON LIMITED06. Okt. 200406. Okt. 2004
    PREMIUM EPSILON LIMITED22. Okt. 199322. Okt. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Richard Holt Evans als Geschäftsführer am 31. Juli 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark John Tottman als Direktor am 31. Juli 2023

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    16 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Richard Holt Evans am 02. Mai 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN zum 7 Duncan Street Edinburgh EH9 1SZ am 08. März 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name23. Feb. 2018

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. Feb. 2018

    RES15

    Cessation of Catlin (Pul) Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2017

    1 SeitenPSC07

    Notification of Nomina Services Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2017

    2 SeitenPSC02

    Ernennung von Jeremy Richard Holt Evans als Direktor am 14. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAMPDEN LEGAL PLC
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    Sekretär
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer01988859
    56301100002
    TOTTMAN, Mark John
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishUnderwriting Agent72513380002
    NOMINA PLC
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer03382553
    81968410003
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Sekretär
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Sekretär
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British100201680002
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Sekretär
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Sekretär
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    BritishDirector70960040001
    REES, Marie Louise
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Sekretär
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    201004110001
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Sekretär
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Bevollmächtigter Sekretär
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Sekretär
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    WELLINGTON INSURANCE LIMITED
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    Sekretär
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    100566440001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUkCompany Director37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishInsurance Executive148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrishActuary240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director6386010002
    CALLAN, Robert
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishAccountant130365420001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director84410430001
    EVANS, Jeremy Richard Holt
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishCompany Director161542790001
    FRESHWATER, Neil Andrew
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishAccountant125646370001
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Geschäftsführer
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    BritishCompany Director9580170001
    HOOK, Christian Robert Macnachtan
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Geschäftsführer
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    BritishSolicitor45036950001
    IBESON, David Christopher Ben
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishActuary52745170002
    IBESON, David Christopher Ben
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishActuary52745170002
    IVORY, Ian Eric
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishInvestment Manager69668870001
    JARDINE, Paul Andrew
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritishActuary62337170003
    JENNER, Michael Eugene
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    BritishInsurance Broker12441700001
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Geschäftsführer
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    EnglandBritish,AmericanCompany Director54716770009
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Geschäftsführer
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritishBusinessman685750001
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    BritishDirector70960040001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Geschäftsführer
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritishCompany Director137567870001
    PRIMER, Daniel Francis
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomAmericanLawyer112177980002
    SHAH, Nylesh
    22 Linkside
    Woodside Park
    N12 7LF London
    Geschäftsführer
    22 Linkside
    Woodside Park
    N12 7LF London
    EnglandBritishActuary87504090001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    14. Dez. 2017
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03603617
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (Scotland)
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc147137
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deposit trust deed
    Erstellt am 20. Mai 2010
    Geliefert am 08. Juni 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All the future profits of the underwriting business of the company at lloyds subject to any prior charge contained in the premiums trust deed.
    Berechtigte Personen
    • Lloyd's
    Transaktionen
    • 08. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Lloyd's security & trust deed
    Erstellt am 20. Mai 2010
    Geliefert am 08. Juni 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    As security for the secured obligations referred to in paragraph 1 under “amounts secured all moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees (being the society and the other trustees for the time being of the trusts created by the trust deed) and all accumulations of income and the investments and other property for the time being representing the same. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyd's
    Transaktionen
    • 08. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Amendment and restatement lloyd's american instrument 1995
    Erstellt am 24. März 2009
    Geliefert am 14. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All losses, claims, returns of premiums, re-insurance premiums and other outgoings in connection with the 1992 and prior american business
    Kurze Angaben
    All present and future assets including all premiums, reinsurance recoveries and other monies in connection with the members new american general business - see form 410 schedule for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 05. Mai 2009
    Lloyd's american trust deed
    Erstellt am 24. März 2009
    Geliefert am 14. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All losses, claims, returns of premiums, re-insurance premiums and other outgoings in connection with the 1992 and prior american business
    Kurze Angaben
    All premiums and other moneys payable during the trust term to or for the account - see form 410 schedule for full details.
    Berechtigte Personen
    • The American Trustee
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 05. Mai 2009
    Deposit trust deed (third party deposit)
    Erstellt am 15. Juni 2007
    Geliefert am 20. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the obligations and sums payable
    Kurze Angaben
    All moneys or other property, all future profits of the underwriting business and the moneys or other property approved - see form 410 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyd's
    Transaktionen
    • 20. Juni 2007Registrierung einer Belastung (410)
    • 17. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Security and trust deed (letter of credit and bank guarantee)
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 22. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. All future underwriting profits. See form 410 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (410)
    • 17. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Security and trust deed (letter of credit and bank guarantee)
    Erstellt am 01. Jan. 2006
    Geliefert am 06. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees for the time being.
    Berechtigte Personen
    • Lloyd's
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (410)
    Trust deed
    Erstellt am 01. Jan. 2004
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The property constituting the trust principal but excluding the investment income from time to time earned thereon-see form 410 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyd's and Another as Trustee
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (410)
    Security and trust deed
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 20. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All moneys or other property and all future profits of the underwriting business. See original mortgage document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds asia (offshire policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members)
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 25. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted offshore policies trust outgoings
    Kurze Angaben
    All the present and future assets of the member comprised in the members offshire policies trust fund constituted under and pursuant to the offshore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of s chedule 2 to the offshore policies instrument--see mort doc for full listing.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds asia (singapore policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members)
    Erstellt am 13. Feb. 2002
    Geliefert am 25. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, rerturn of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted singaport policies trust outgoings
    Kurze Angaben
    All the present and future assets of the member comprised in the members singapore policies trust fund constituted under and pursuant to the singapore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of schedule 2 to the singapore policies instrument--see mort doc for full listing.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds united states situs credit for reinsurance trust deed
    Erstellt am 03. Jan. 2002
    Geliefert am 22. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The payment of all expenditure and fees of the trustee
    Kurze Angaben
    The principal at any time but excluding the investment income from time to time earned thereon.
    Berechtigte Personen
    • Citibank N.A.
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds canadian trust deed
    Erstellt am 25. Mai 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted canadian trust outgoings
    Kurze Angaben
    All the present and future assets of the member comprised in the members canadian trust fund constituted under and pursuant to the lloyds canadian trust deed full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the lloyds canadian trust deed, including the following (I) all premiums, reinsurance recoveries, rights of salvage and subrogation and other monies whatsoever in connection with the members canadian business and all other interest of the member therin (ii) all canadian rights of recovery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds canadian margin fund trust deed
    Erstellt am 25. Mai 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Trustee priority claims
    Kurze Angaben
    All interest of the company in present and future assets comprised in the margin fund constituted under the trust deed including the following a) the contributions paid to the margin fund by or on behalf of the company pursuant to the lloyds canadian business requirements 2001 made by the council of lloyds or any other requirements of the council of lloyds. B)all monies, investments, income, gains or other asets at any time representing or accruing to the contributions referred to above.
    Berechtigte Personen
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds illinois licensed and 1104 multiple trust deed
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Any sum of money which is or becomes payable to a policyholder to pay a claim arising under an illinois policy
    Kurze Angaben
    õAll present and future assets comprised in the corporated members trust fund constituted under and pursuant to the trust deed, including all monies (including future accretions to the trust fund), investments, income, gains and other assets representing oraccruing to that trust fund.
    Berechtigte Personen
    • Mellon Trust Company
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (410)
    Amendment and restatement lloyd's american instrument 1995
    Erstellt am 28. Dez. 2000
    Geliefert am 17. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted dollar trust outgoings"
    Kurze Angaben
    All the present and future assets of the member comprised in the m embersdollar trust fund constituted under and pursuant to the 1995 american instrumen (corporate member) full particulars of which assets are set out in clause 3 ofand schedule 2 to the 1995 american instrument (corporate members)-see mortgagedocument for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Society Incorporated by Lloyds Act 1871 by the Name of Lloyd's
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds canadian trust deed
    Erstellt am 28. Dez. 2000
    Geliefert am 17. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, return of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted canadian trust outgoings"
    Kurze Angaben
    All the present and future assets of the member comprised in the m embers canadian trust fund constituted under and pursuant to the lloyds canadian trust deed full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the lloyds canadian trust deed- see mortgage document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds australian joint asset trust deed (no.1)
    Erstellt am 06. Juni 2000
    Geliefert am 22. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Kurze Angaben
    All the present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to the trust fund.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 22. Juni 2000Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds australian joint asset trust deed (no.2)
    Erstellt am 06. Juni 2000
    Geliefert am 22. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Kurze Angaben
    All the present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to the trust fund.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 22. Juni 2000Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds australian trust deed
    Erstellt am 06. Juni 2000
    Geliefert am 22. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Kurze Angaben
    The share of the corporate member in all present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to that share.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds
    Transaktionen
    • 22. Juni 2000Registrierung einer Belastung (410)
    Lloyds premiums trust deed
    Erstellt am 01. Jan. 1999
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted trust outgoings"
    Kurze Angaben
    All thepresent and future assets of the corporate members comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed full particulars which assets are set out in clause 2 and schedule 2 to the trust deed.
    Berechtigte Personen
    • The Society Incorporated by Lloyds Act 1871 by the Name of Lloyds
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (410)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 01. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (410)
    • 02. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Kurze Angaben
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (410)
    • 02. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Kurze Angaben
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (410)
    • 02. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Kurze Angaben
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (410)
    • 02. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0