KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED

KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC147319
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    • Tätigkeit von Versicherungsvertretern und -maklern (66220) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor North Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KFI LIMITED19. Juli 199419. Juli 1994
    KWIK-FIT FINANCIAL SERVICES LIMITED16. Dez. 199316. Dez. 1993
    DMWS 236 LIMITED04. Nov. 199304. Nov. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Claire Catherine Marsh als Sekretär am 01. Nov. 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Rosemary Anne Smith als Sekretär am 01. Nov. 2019

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Fernley Keith Dyson als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    14 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 08. Aug. 2018

    • Kapital: GBP 0.10
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Edward Middle am 23. Apr. 2018

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Fernley Keith Dyson am 29. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Kapitalaufstellung am 15. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 5,000.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 14/12/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Ageas (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Erfüllung der Belastung SC1473190005 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1473190004 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARSH, Claire Catherine
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    Sekretär
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    264201510001
    MIDDLE, Anthony Edward
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector129283070002
    ALLAN, June Lynch
    Masterton Way
    Tannochside Business Park
    G71 5PU Uddingston
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    Masterton Way
    Tannochside Business Park
    G71 5PU Uddingston
    1
    United Kingdom
    British147440480001
    LAWSON, Barry Alexander
    Fernlea
    Bearsden
    G61 1NB Glasgow
    36
    United Kingdom
    Sekretär
    Fernlea
    Bearsden
    G61 1NB Glasgow
    36
    United Kingdom
    British115764610003
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Sekretär
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    BritishFinancial Analyst41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    SMITH, Rosemary Anne
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    Sekretär
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    153430430001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BALL, Gregor Frank
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director108633100001
    BANWELL, Jason David
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector182498480001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Geschäftsführer
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    BritishGroup Director Of Finance79800380001
    BRIGHT, Robert Stewart
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector145809660001
    BROWN, Alan
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector135011840001
    BRUCE, Roderick Lawrence
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Rosehill
    23 Inveresk Village
    Inveresk
    East Lothian
    British900003110001
    CLIFF, Mark
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector197694550001
    CONNOR, Raymond Thomas
    St Swithin's Cottage
    EH26 9LZ Ninemileburn
    Midlothian
    Geschäftsführer
    St Swithin's Cottage
    EH26 9LZ Ninemileburn
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor362260001
    DEVINE, Brendan
    Masterton Way
    Tannochside Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United KingdomBritishCompany Director113265830001
    DIMARCO, Dominic
    3670 South Eiden
    MI 48324 West Bloomfield
    Mi48324
    U S A
    Geschäftsführer
    3670 South Eiden
    MI 48324 West Bloomfield
    Mi48324
    U S A
    AmericanDirector72024300001
    DIMARCO, Dominic
    3670 South Eiden
    MI 48324 West Bloomfield
    Mi48324
    U S A
    Geschäftsführer
    3670 South Eiden
    MI 48324 West Bloomfield
    Mi48324
    U S A
    AmericanDirector72024300001
    DYSON, Fernley Keith
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    2nd Floor North
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector127180610002
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Geschäftsführer
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Geschäftsführer
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUkCompany Director28393850006
    FRIEND, Peter Richard Henry
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector14914420007
    FURSE, James Richard John
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director147085440001
    HARVEY, Julian Robert Mark
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector161523620001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Geschäftsführer
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director99111340001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    4a Essex Brae
    Barnton
    EH4 6LN Edinburgh
    Geschäftsführer
    4a Essex Brae
    Barnton
    EH4 6LN Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director99111340001
    HEWITT, Ronald James
    19 Great Stuart Street
    EH3 7TP Edinburgh
    Mid-Lothian
    Geschäftsführer
    19 Great Stuart Street
    EH3 7TP Edinburgh
    Mid-Lothian
    BritishManaging Director40399780003
    HOOD, Neil, Professor
    95 Mote Hill
    ML3 6EA Hamilton
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    95 Mote Hill
    ML3 6EA Hamilton
    Lanarkshire
    BritishDirector127480002
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Geschäftsführer
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    BritishDirector712840002
    JONES, Ruth
    16784 Dundalk Ct
    Northville
    Mi 48167
    United States Of America
    Geschäftsführer
    16784 Dundalk Ct
    Northville
    Mi 48167
    United States Of America
    AmericanDirector79996170001
    JONES, Ruth
    16784 Dundalk Ct
    Northville
    Mi 48167
    United States Of America
    Geschäftsführer
    16784 Dundalk Ct
    Northville
    Mi 48167
    United States Of America
    AmericanDirector79996170001
    LANDAU, Ervin
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    Geschäftsführer
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    United KingdomBritishSolicitor91134410001
    LEMANS, Nicholas James
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector114355520002
    LYNCH, June
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Masterton Way
    Tannochside Business Park, Uddingston
    G71 5PU Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director154407880002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01093301
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 17. Sept. 2014
    Geliefert am 01. Okt. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    (1) by way of first legal mortgage, all of the specified real property and all other real property now vested in the company; (2) by way of first fixed charge all the company’s present and future right, title and interest in and to and the benefit of (but in the case of paragraphs (v) and (vi) of clause 3.1(b) of the debenture only if and to the extent the rights in question have not been effectively assigned pursuant to clause 4.1 of the debenture (assignments) or such rights have been effectively assigned but such assignment has not been perfected by the service of the appropriate notice): (I) to the extent not effectively charged pursuant to (1) above, all estates or interests in any real property (whether such interests are freehold, leasehold or licences) vested in, or acquired by, it.. For the purpose of this application for registration "specified real property" means (a) the real property identified in schedule 1 of the debenture (details of certain assets) (if any); and (b) all other real property legally or beneficially owned by the company which is designated as "specified real property" by the security agent and the company. "Real property" means (a) any freehold, leasehold or immovable property and all rights, easements and privileges from time to time attached thereto; and (b) any buildings and fixtures from time to time situated on or forming part of that freehold, leasehold or immovable property. "Fixtures" means in relation to any real property, all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant, machinery and equipment and other items attached to the relevant real property whether or not constituting a fixture at law. "Secured parties" means each of the finance parties, any delegate and any receiver. "Finance party" means the agent, the arranger, the security agent or any lender under the facility agreement (as each is defined therein). "Delegate" means any delegate, agent, attorney or co-trustee appointed by the security agent. "Receiver" means a receiver and manager or any other receiver (whether appointed pursuant to this debenture or any statute, by a court or otherwise) of all or any of the secured assets and shall, where permitted by law, include an administrative receiver. "Secured assets" means all of the assets, rights, title, interests and benefits of the company from time to time subject to the security. "Security" means the security created or intended to be created by this debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited as Trustee for the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Sept. 2014
    Geliefert am 30. Sept. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land subject to a fixed charge but for the purpose of this application for registration "secured parties" means each finance party from time to time party to the facility agreement and any receiver or delegate.. "Finance party" means the agent, the arranger, the security agent or any lender under the facility agreement (as each is defined therein).. "Delegate" means any delegate, agent, attorney or co-trustee appointed by the security agent.. "Receiver" means a receiver or receiver and manager or administrative receiver of the whole or any part of the charged property (as defined in the facility agreement).
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited as Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 20. Sept. 2011
    Geliefert am 24. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 15. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 24. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (410)
    • 28. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 28. Apr. 2003
    Geliefert am 01. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 01. Mai 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 28. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0