KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | SC147319 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
- Tätigkeit von Versicherungsvertretern und -maklern (66220) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor North Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
KFI LIMITED | 19. Juli 1994 | 19. Juli 1994 |
KWIK-FIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | 16. Dez. 1993 | 16. Dez. 1993 |
DMWS 236 LIMITED | 04. Nov. 1993 | 04. Nov. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Claire Catherine Marsh als Sekretär am 01. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rosemary Anne Smith als Sekretär am 01. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fernley Keith Dyson als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Aug. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Edward Middle am 23. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Fernley Keith Dyson am 29. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Dez. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Nov. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Ageas (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1473190005 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1473190004 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSH, Claire Catherine | Sekretär | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh 2nd Floor North United Kingdom | 264201510001 | |||||||
MIDDLE, Anthony Edward | Geschäftsführer | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh 2nd Floor North United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 129283070002 | ||||
ALLAN, June Lynch | Sekretär | Masterton Way Tannochside Business Park G71 5PU Uddingston 1 United Kingdom | British | 147440480001 | ||||||
LAWSON, Barry Alexander | Sekretär | Fernlea Bearsden G61 1NB Glasgow 36 United Kingdom | British | 115764610003 | ||||||
MCGILL, Kenneth Andrew | Sekretär | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | Financial Analyst | 41923940001 | |||||
MORRISON, Scott | Sekretär | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
SMITH, Rosemary Anne | Sekretär | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh 2nd Floor North United Kingdom | 153430430001 | |||||||
DM COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
BALL, Gregor Frank | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 108633100001 | ||||
BANWELL, Jason David | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 182498480001 | ||||
BISSETT, Graeme | Geschäftsführer | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | Group Director Of Finance | 79800380001 | |||||
BRIGHT, Robert Stewart | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | England | British | Director | 145809660001 | ||||
BROWN, Alan | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | Director | 135011840001 | ||||
BRUCE, Roderick Lawrence | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Rosehill 23 Inveresk Village Inveresk East Lothian | British | 900003110001 | ||||||
CLIFF, Mark | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 197694550001 | ||||
CONNOR, Raymond Thomas | Geschäftsführer | St Swithin's Cottage EH26 9LZ Ninemileburn Midlothian | Scotland | British | Solicitor | 362260001 | ||||
DEVINE, Brendan | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 | United Kingdom | British | Company Director | 113265830001 | ||||
DIMARCO, Dominic | Geschäftsführer | 3670 South Eiden MI 48324 West Bloomfield Mi48324 U S A | American | Director | 72024300001 | |||||
DIMARCO, Dominic | Geschäftsführer | 3670 South Eiden MI 48324 West Bloomfield Mi48324 U S A | American | Director | 72024300001 | |||||
DYSON, Fernley Keith | Geschäftsführer | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh 2nd Floor North United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127180610002 | ||||
FARMER, Thomas, Sir | Geschäftsführer | 192 Queensferry Road EH4 6JL Edinburgh Maidencraig House Midlothian | Scotland | British | Director | 94804240004 | ||||
FRASER, Ian Ellis | Geschäftsführer | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | Scotland | Uk | Company Director | 28393850006 | ||||
FRIEND, Peter Richard Henry | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | England | British | Director | 14914420007 | ||||
FURSE, James Richard John | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | England | British | Company Director | 147085440001 | ||||
HARVEY, Julian Robert Mark | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 161523620001 | ||||
HEALY, Michael Joseph Anthony | Geschäftsführer | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | Company Director | 99111340001 | ||||
HEALY, Michael Joseph Anthony | Geschäftsführer | 4a Essex Brae Barnton EH4 6LN Edinburgh | United Kingdom | British | Company Director | 99111340001 | ||||
HEWITT, Ronald James | Geschäftsführer | 19 Great Stuart Street EH3 7TP Edinburgh Mid-Lothian | British | Managing Director | 40399780003 | |||||
HOOD, Neil, Professor | Geschäftsführer | 95 Mote Hill ML3 6EA Hamilton Lanarkshire | British | Director | 127480002 | |||||
HOUSTON, John Mclellan | Geschäftsführer | The Rock 3 Douglas Avenue PA14 6PE Langbank | British | Director | 712840002 | |||||
JONES, Ruth | Geschäftsführer | 16784 Dundalk Ct Northville Mi 48167 United States Of America | American | Director | 79996170001 | |||||
JONES, Ruth | Geschäftsführer | 16784 Dundalk Ct Northville Mi 48167 United States Of America | American | Director | 79996170001 | |||||
LANDAU, Ervin | Geschäftsführer | 78 Harley House Marylebone Road NW1 5HN London | United Kingdom | British | Solicitor | 91134410001 | ||||
LEMANS, Nicholas James | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 114355520002 | ||||
LYNCH, June | Geschäftsführer | Masterton Way Tannochside Business Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 154407880002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ageas (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat KWIK-FIT INSURANCE SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 17. Sept. 2014 Geliefert am 01. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung (1) by way of first legal mortgage, all of the specified real property and all other real property now vested in the company; (2) by way of first fixed charge all the company’s present and future right, title and interest in and to and the benefit of (but in the case of paragraphs (v) and (vi) of clause 3.1(b) of the debenture only if and to the extent the rights in question have not been effectively assigned pursuant to clause 4.1 of the debenture (assignments) or such rights have been effectively assigned but such assignment has not been perfected by the service of the appropriate notice): (I) to the extent not effectively charged pursuant to (1) above, all estates or interests in any real property (whether such interests are freehold, leasehold or licences) vested in, or acquired by, it.. For the purpose of this application for registration "specified real property" means (a) the real property identified in schedule 1 of the debenture (details of certain assets) (if any); and (b) all other real property legally or beneficially owned by the company which is designated as "specified real property" by the security agent and the company. "Real property" means (a) any freehold, leasehold or immovable property and all rights, easements and privileges from time to time attached thereto; and (b) any buildings and fixtures from time to time situated on or forming part of that freehold, leasehold or immovable property. "Fixtures" means in relation to any real property, all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant, machinery and equipment and other items attached to the relevant real property whether or not constituting a fixture at law. "Secured parties" means each of the finance parties, any delegate and any receiver. "Finance party" means the agent, the arranger, the security agent or any lender under the facility agreement (as each is defined therein). "Delegate" means any delegate, agent, attorney or co-trustee appointed by the security agent. "Receiver" means a receiver and manager or any other receiver (whether appointed pursuant to this debenture or any statute, by a court or otherwise) of all or any of the secured assets and shall, where permitted by law, include an administrative receiver. "Secured assets" means all of the assets, rights, title, interests and benefits of the company from time to time subject to the security. "Security" means the security created or intended to be created by this debenture. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 17. Sept. 2014 Geliefert am 30. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung No land subject to a fixed charge but for the purpose of this application for registration "secured parties" means each finance party from time to time party to the facility agreement and any receiver or delegate.. "Finance party" means the agent, the arranger, the security agent or any lender under the facility agreement (as each is defined therein).. "Delegate" means any delegate, agent, attorney or co-trustee appointed by the security agent.. "Receiver" means a receiver or receiver and manager or administrative receiver of the whole or any part of the charged property (as defined in the facility agreement). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed & floating charge | Erstellt am 20. Sept. 2011 Geliefert am 24. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 24. Feb. 2004 Geliefert am 11. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Bond & floating charge | Erstellt am 28. Apr. 2003 Geliefert am 01. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0