S 83 LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameS 83 LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC148181
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von S 83 LTD?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich S 83 LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    14 Rutland Square
    Edinburgh
    EH1 2BD Midlothian
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von S 83 LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    83 SS LTD14. Juni 201614. Juni 2016
    83 S LTD02. Sept. 200802. Sept. 2008
    FORT TRADING LIMITED23. Dez. 199323. Dez. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von S 83 LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für S 83 LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Mai 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Konten eines kleinen Unternehmens mit voller Befreiung erstellt bis 31. Mai 2016

    6 SeitenAAMD

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    9 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2016

    7 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung SC1481810024 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810022 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810023 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810019 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810012 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung SC1481810010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name14. Juni 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 14. Juni 2016

    RES15

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed 83 s LTD\certificate issued on 14/06/16
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name14. Juni 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 14. Juni 2016

    RES15

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 31. Mai 2016

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung SC1481810024, erstellt am 25. März 2015

    7 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von S 83 LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Victoria Caroline
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Sekretär
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    British99461500002
    JONES, Steven Alexander
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish99461360007
    JONES, Victoria Caroline, Mrs.
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Stenton Estate
    PH8 0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish160627090001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Sekretär
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    British37119590005
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    HENDERSON, Elaine Catherine
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    Geschäftsführer
    Stonefield House
    22 Park Road
    EH11 3DH Dalkeith
    ScotlandBritish37119590005
    JONES, James
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    22 Blackford Hill View
    EH9 3HD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish902280001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei S 83 LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    06. Apr. 2016
    EH1 2BD Edinburgh
    14 Rutland Square
    Midlothian
    Scotland
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc105694
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr Steven Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mrs Victoria Caroline Jones
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    PH8-0JB Dunkeld
    Stenton Estate
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat S 83 LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. März 2015
    Geliefert am 02. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    68 hillhouse road, hamilton - title number LAN153173.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Feb. 2015
    Geliefert am 10. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    56 shandwick place, edinburgh. Basement premises of tenement 54 & 56 shandwick place, edinburgh title number MID123979.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Adam & Co PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Feb. 2015
    Geliefert am 10. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    11 north bank street, edinburgh. Title number MID157218.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Okt. 2013
    Geliefert am 25. Okt. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects in the city parish of edinburgh and county of midlothian (formerly edinburgh) and known as number seventeen ainslie place, edinburgh being the subjects shown delineated and hatched in red on the plan annexed and signed as relative hereto, together with the common property with all the other feuars of the grounds of drumsheugh, in the pleasure grounds of moray place and ainslie place and the banks behind the same being the subjects in the said parish and county described (firstly) and (secondly) in the disposition by testamentary trustees of mrs bella lindsay or edgecombe in favour of the minister of works dated twentieth and twenty first and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on thirtieth all days of march nineteen hundred and fifty one; together also with the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, the fittings and fixtures therein and thereon, and the borrower's whole right, title and interest present and future therein and thereto. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Victoria Caroline Jones
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Aug. 2013
    Geliefert am 20. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    6 walker street edinburgh MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Aug. 2013
    Geliefert am 17. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    9 north bank street edinburgh MID131862. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Aug. 2013
    Geliefert am 15. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juni 2013
    Geliefert am 21. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the ground floor garage premises known as 101 - 103 rose street north lane, edinburgh forming the ground floor of the building comprising garage premises and workshop premises above known as 101 and 103 rose street north lane, edinburgh, being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID110233. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Victoria Caroline Jones
    Transaktionen
    • 21. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 13. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Subjects known as and forming 32 castle street edinburgh. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Juni 2013
    Geliefert am 17. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects known as and forming numbers 19 and 20 coates crescent, edinburgh and for the purpose of registration of writs, in the county of midlothian comprising (first) the subjects and others known as number 19 coates crescent, edinburgh in the said county with the solum thereof and ground attached thereto being the subjects more particularly described in and disponed by charter by sir patrick walker of coates with consent thereinmentioned in favour of mrs clara miller and another dated 1 march 1822 with instrument of sasine following thereon in favour of mrs clara miller and another dated 18 april 1823 and recorded in the new particular register of sasines, reversions etcetera for the sheriffdoms of edinburgh and haddington, linlithgow and bathgate on 14 may 1823; together with the cellars under the pavement in front, sunk area, back ground and others effeiring thereto; (second) the subjects known as number 20 coates crescent, edinburgh in the said county together with the cellarage under the pavement in front opposite thereto and the whole other parts, privileges and pertinents effeiring thereto, being the subjects more particularly described in and disponed by disposition by the trustees of the honourable james craufurd, lord ardmillan, with consent thereinmentioned in favour of miss margaret wright dated 3 november 1903 and subsequent dates and recorded in the division of the general register of sasines for the county of edinburgh (now midlothian) on 28 november 1903; which said subjects hereinbefore described (first) and (second) are shown delineated in red on the plan annexed and executed as relative hereto; and (third) a one-half pro indiviso share of all and whole that strip of ground attached to the subjects forming and known as number 11 manor place, edinburgh (which strip of ground forms part of the access to the car park constructed on part of inter alia the subjects (first) and (second) hereinbefore described) in the said county being the subjects shown coloured purple on the said plan annexed and executed as relative hereto and being the subjects more particularly described in and disponed by and delineated and coloured red on the plan annexed and signed as relative to disposition by robert williamson gardiner in favour of mccallum advertising limited and the royal institution of chartered surveyors (therein erroneously referred to as "the scottish branch of the royal institution of chartered surveyors") dated 21 february 1966 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 23 february 1966; together also with in relation to the subjects (first), (second) and (third) hereinbefore described (one) the heritable and irredeemable servitude rights of wayleave, passage, access, use and others specified and contained in minute of agreement between the drambuie liqueur company limited and the royal institution of chartered surveyors dated 2 june and 31 july 1967 and recorded in the said division of the general register of sasines and also in the books of council & session on 7 august 1967; (two) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto; (three) the fittings and fixtures therein and thereon; and (four) the borrower's whole right, title and interest, present and future, therein and thereto; excepting always from the subjects hereinbefore described any rights in coates crescent gardens which were conveyed by disposition by the trustees of adam p nimmo and others to the lord provost, magistrates and council of the city of edinburgh recorded in the said division of the general register of sasines on 29 october 1957. notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Victoria Caroline Jones
    Transaktionen
    • 17. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Juni 2013
    Geliefert am 17. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects forming 8 kew terrace, edinburgh, EH12 5JE being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID53770. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Victoria Caroline Jones
    Transaktionen
    • 17. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2013
    Geliefert am 07. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Mai 2013
    Geliefert am 08. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    235 willowbrae road edinburgh see form for details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Mai 2013
    Geliefert am 08. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    358 to 362 morning road edinburgh MID68005. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Mai 2013
    Geliefert am 09. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    6 walker street, edinburgh registered under title number MID143865. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Apr. 2013
    Geliefert am 07. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 22. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 24. Feb. 2009
    Geliefert am 28. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    4 walker street, edinburgh MID121987.
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 16. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 13. Dez. 2007
    Geliefert am 21. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    235 willowbrae road, edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (410)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 23. Nov. 2007
    Geliefert am 13. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Adam & Company PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (410)
    • 02. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 19. Dez. 1996
    Geliefert am 31. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    235 willowbrae road,edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (410)
    • 08. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 02. Aug. 1996
    Geliefert am 07. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (410)
    • 08. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Standard security
    Erstellt am 17. März 1994
    Geliefert am 22. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Willowbrae service station,235 willowbrae road,edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 1994Registrierung einer Belastung (410)
    • 08. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. März 1994
    Geliefert am 03. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1994Registrierung einer Belastung (410)
    • 17. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0