S 83 LTD
Überblick
| Unternehmensname | S 83 LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC148181 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von S 83 LTD?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich S 83 LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 14 Rutland Square Edinburgh EH1 2BD Midlothian |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von S 83 LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 83 SS LTD | 14. Juni 2016 | 14. Juni 2016 |
| 83 S LTD | 02. Sept. 2008 | 02. Sept. 2008 |
| FORT TRADING LIMITED | 23. Dez. 1993 | 23. Dez. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von S 83 LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für S 83 LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Mai 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Konten eines kleinen Unternehmens mit voller Befreiung erstellt bis 31. Mai 2016 | 6 Seiten | AAMD | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810024 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810022 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810023 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810019 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810017 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810018 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung SC1481810010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed 83 s LTD\certificate issued on 14/06/16 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 31. Mai 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung SC1481810024, erstellt am 25. März 2015 | 7 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von S 83 LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Victoria Caroline | Sekretär | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | British | 99461500002 | ||||||
| JONES, Steven Alexander | Geschäftsführer | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | United Kingdom | British | 99461360007 | |||||
| JONES, Victoria Caroline, Mrs. | Geschäftsführer | Stenton Estate PH8 0JB Dunkeld Stenton Estate Perthshire Scotland | United Kingdom | British | 160627090001 | |||||
| HENDERSON, Elaine Catherine | Sekretär | Stonefield House 22 Park Road EH11 3DH Dalkeith | British | 37119590005 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| HENDERSON, Elaine Catherine | Geschäftsführer | Stonefield House 22 Park Road EH11 3DH Dalkeith | Scotland | British | 37119590005 | |||||
| JONES, James | Geschäftsführer | 22 Blackford Hill View EH9 3HD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 902280001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei S 83 LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 S Limited | 06. Apr. 2016 | EH1 2BD Edinburgh 14 Rutland Square Midlothian Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Steven Jones | 06. Apr. 2016 | PH8-0JB Dunkeld Stenton Estate United Kingdom | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Victoria Caroline Jones | 06. Apr. 2016 | PH8-0JB Dunkeld Stenton Estate United Kingdom | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat S 83 LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. März 2015 Geliefert am 02. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 68 hillhouse road, hamilton - title number LAN153173. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Feb. 2015 Geliefert am 10. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 56 shandwick place, edinburgh. Basement premises of tenement 54 & 56 shandwick place, edinburgh title number MID123979. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Feb. 2015 Geliefert am 10. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 11 north bank street, edinburgh. Title number MID157218. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. Okt. 2013 Geliefert am 25. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects in the city parish of edinburgh and county of midlothian (formerly edinburgh) and known as number seventeen ainslie place, edinburgh being the subjects shown delineated and hatched in red on the plan annexed and signed as relative hereto, together with the common property with all the other feuars of the grounds of drumsheugh, in the pleasure grounds of moray place and ainslie place and the banks behind the same being the subjects in the said parish and county described (firstly) and (secondly) in the disposition by testamentary trustees of mrs bella lindsay or edgecombe in favour of the minister of works dated twentieth and twenty first and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of midlothian (formerly edinburgh) on thirtieth all days of march nineteen hundred and fifty one; together also with the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, the fittings and fixtures therein and thereon, and the borrower's whole right, title and interest present and future therein and thereto. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 13. Aug. 2013 Geliefert am 20. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 6 walker street edinburgh MID143865. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 13. Aug. 2013 Geliefert am 17. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 9 north bank street edinburgh MID131862. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 13. Aug. 2013 Geliefert am 15. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Juni 2013 Geliefert am 21. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the ground floor garage premises known as 101 - 103 rose street north lane, edinburgh forming the ground floor of the building comprising garage premises and workshop premises above known as 101 and 103 rose street north lane, edinburgh, being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID110233. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Juni 2013 Geliefert am 13. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Subjects known as and forming 32 castle street edinburgh. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Juni 2013 Geliefert am 17. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects known as and forming numbers 19 and 20 coates crescent, edinburgh and for the purpose of registration of writs, in the county of midlothian comprising (first) the subjects and others known as number 19 coates crescent, edinburgh in the said county with the solum thereof and ground attached thereto being the subjects more particularly described in and disponed by charter by sir patrick walker of coates with consent thereinmentioned in favour of mrs clara miller and another dated 1 march 1822 with instrument of sasine following thereon in favour of mrs clara miller and another dated 18 april 1823 and recorded in the new particular register of sasines, reversions etcetera for the sheriffdoms of edinburgh and haddington, linlithgow and bathgate on 14 may 1823; together with the cellars under the pavement in front, sunk area, back ground and others effeiring thereto; (second) the subjects known as number 20 coates crescent, edinburgh in the said county together with the cellarage under the pavement in front opposite thereto and the whole other parts, privileges and pertinents effeiring thereto, being the subjects more particularly described in and disponed by disposition by the trustees of the honourable james craufurd, lord ardmillan, with consent thereinmentioned in favour of miss margaret wright dated 3 november 1903 and subsequent dates and recorded in the division of the general register of sasines for the county of edinburgh (now midlothian) on 28 november 1903; which said subjects hereinbefore described (first) and (second) are shown delineated in red on the plan annexed and executed as relative hereto; and (third) a one-half pro indiviso share of all and whole that strip of ground attached to the subjects forming and known as number 11 manor place, edinburgh (which strip of ground forms part of the access to the car park constructed on part of inter alia the subjects (first) and (second) hereinbefore described) in the said county being the subjects shown coloured purple on the said plan annexed and executed as relative hereto and being the subjects more particularly described in and disponed by and delineated and coloured red on the plan annexed and signed as relative to disposition by robert williamson gardiner in favour of mccallum advertising limited and the royal institution of chartered surveyors (therein erroneously referred to as "the scottish branch of the royal institution of chartered surveyors") dated 21 february 1966 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 23 february 1966; together also with in relation to the subjects (first), (second) and (third) hereinbefore described (one) the heritable and irredeemable servitude rights of wayleave, passage, access, use and others specified and contained in minute of agreement between the drambuie liqueur company limited and the royal institution of chartered surveyors dated 2 june and 31 july 1967 and recorded in the said division of the general register of sasines and also in the books of council & session on 7 august 1967; (two) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto; (three) the fittings and fixtures therein and thereon; and (four) the borrower's whole right, title and interest, present and future, therein and thereto; excepting always from the subjects hereinbefore described any rights in coates crescent gardens which were conveyed by disposition by the trustees of adam p nimmo and others to the lord provost, magistrates and council of the city of edinburgh recorded in the said division of the general register of sasines on 29 october 1957. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Juni 2013 Geliefert am 17. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects forming 8 kew terrace, edinburgh, EH12 5JE being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID53770. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Mai 2013 Geliefert am 07. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Mai 2013 Geliefert am 08. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 235 willowbrae road edinburgh see form for details. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Mai 2013 Geliefert am 08. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 358 to 362 morning road edinburgh MID68005. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Mai 2013 Geliefert am 09. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 6 walker street, edinburgh registered under title number MID143865. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Apr. 2013 Geliefert am 07. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 24. Feb. 2009 Geliefert am 28. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 4 walker street, edinburgh MID121987. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 235 willowbrae road, edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond & floating charge | Erstellt am 23. Nov. 2007 Geliefert am 13. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 19. Dez. 1996 Geliefert am 31. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 235 willowbrae road,edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond & floating charge | Erstellt am 02. Aug. 1996 Geliefert am 07. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 17. März 1994 Geliefert am 22. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Willowbrae service station,235 willowbrae road,edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 02. März 1994 Geliefert am 03. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0