LOGIERAIT BRIDGE COMPANY
Überblick
| Unternehmensname | LOGIERAIT BRIDGE COMPANY |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
| Unternehmensnummer | SC151036 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 51 Atholl Road Pitlochry PH16 5BU Perthshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 11. Okt. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 11. Juli 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Okt. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Mai 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 06. Juni 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Mai 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr Peter Anthony Clark als Direktor am 05. Juni 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Dr James David Salisbury als Direktor am 05. Juni 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2024 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Donald John Maclean am 10. Apr. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von J & H Mitchell Ws als Sekretär am 30. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Philip Chetwynd Fry als Geschäftsführer am 06. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Jimmy Mcmenemie als Geschäftsführer am 26. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stanley Bruce als Geschäftsführer am 23. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Norman David Mccandlish als Geschäftsführer am 27. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Philip Chetwynd Fry am 31. Mai 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für J & H Mitchell Ws am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charles Gordon Dilworth als Geschäftsführer am 22. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr George Anthony Wilson als Direktor am 22. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGES, Clive William | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Highfield Scotland | United Kingdom | British | 98399230001 | |||||||||||||
| BURGESS, Anthony, Dr | Geschäftsführer | Strathtay PH9 0PZ Pitlochry Balnamuir House Perth And Kinross Scotland | Scotland | British | 255185130001 | |||||||||||||
| CLARK, Peter Anthony | Geschäftsführer | Logierait PH9 0LH Pitlochry Clais An Deor Perth And Kinross Scotland | Scotland | Scottish | 337051850001 | |||||||||||||
| GRANT, Keith Peter Mark, Dr | Geschäftsführer | Larchwood Road PH16 5AS Pitlochry Corrour Scotland | Scotland | British | 251816320001 | |||||||||||||
| GRANT, Sandra Jane | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Torbeag Perthshire Scotland | Scotland | British | 188228180002 | |||||||||||||
| HOWIE, Kathleen Marion | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LW By Pitlochry Tulloch Of Pitnacree Perthshire | Scotland | British | 129849530002 | |||||||||||||
| MACLEAN, Donald John | Geschäftsführer | Perth Road Birnam PH8 0AA Dunkeld The Retreat Scotland | Scotland | British | 249109650002 | |||||||||||||
| SALISBURY, James David, Dr | Geschäftsführer | Dalguise PH8 0JX Dunkeld Lower Sophia Perth And Kinross Scotland | Scotland | British | 337051320001 | |||||||||||||
| SWINNEY, John Ramsay | Geschäftsführer | Church Road Woodside PH13 9QB Blairgowrie Lyngrove Perthshire Scotland | Scotland | Scottish | 207387880001 | |||||||||||||
| WILSON, George Anthony | Geschäftsführer | Balnamuir Balnaguard PH9 0PZ Pitlochry The Old Toll House Perth And Kinross Scotland | Scotland | British | 264155410001 | |||||||||||||
| DE MAIME BEAUMONT, Deryck | Sekretär | Balnaguard Inn Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | British | 35742300001 | ||||||||||||||
| REID, Brian | Bevollmächtigter Sekretär | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||||||
| J & H MITCHELL WS | Sekretär | Atholl Road PH16 5BU Pitlochry 51 Perthshire Scotland |
| 926840001 | ||||||||||||||
| ALSTON, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | Woodinch Dalguise PH8 0JU Dunkeld Perthshire | British | 40252410001 | ||||||||||||||
| BINNER, Laura Christine | Geschäftsführer | 51 Atholl Road Pitlochry PH16 5BU Perthshire | Scotland | British | 170983540001 | |||||||||||||
| BRADLEY, Patrick Joseph | Geschäftsführer | Upper Farrochil PH15 2EX Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | 55613930001 | |||||||||||||
| BRIDGES, Clive William | Geschäftsführer | Highfield Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Perthshire | United Kingdom | British | 98399230001 | |||||||||||||
| BRUCE, Stanley | Geschäftsführer | Rosebank Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | Scotland | British | 90876490001 | |||||||||||||
| DE MAIME BEAUMONT, Deryck | Geschäftsführer | Balnaguard Inn Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | British | 35742300001 | ||||||||||||||
| DILWORTH, Charles Gordon | Geschäftsführer | Moulin PH16 5EL Pitlochry Baledmund Road Perthshire Scotland | Scotland | Scottish | 129849500001 | |||||||||||||
| FRY, John Philip Chetwynd | Geschäftsführer | Tulloch Of Pitnacree PH9 0LW Pitlochry Tulloch Schoolhouse Scotland | Scotland | British | 161055580002 | |||||||||||||
| GILLESPIE, Iain Machray | Geschäftsführer | Kirkwood Dalguise PH8 0JU Dunkeld Perthshire | Scotland | British | 481020001 | |||||||||||||
| GRANT, Wilma Alison | Geschäftsführer | Balnamuir House Balnaguard PH9 0PZ By Pitlochry | British | 110112250001 | ||||||||||||||
| GUINAN, Peter Howard | Geschäftsführer | Mill Of Logierait Logierait PH9 0LH Pitlochry Perthshire | Scotland | British | 105658740001 | |||||||||||||
| HARVEY, Ian Bruce | Geschäftsführer | The Steading Dalnabo PH9 0NL Ballinluig Perthshire | British | 98967260001 | ||||||||||||||
| MABBOTT, Stephen | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow Strathclyde | British | 900007110001 | ||||||||||||||
| MCCANDLISH, Eileen Marion | Geschäftsführer | Knockintober Ballinluig PH9 0LN Pitlochry Perthshire | British | 70774950001 | ||||||||||||||
| MCCANDLISH, Norman David | Geschäftsführer | Kenmore Street PH15 2BL Aberfeldy 8 Scotland | Scotland | British | 58107230002 | |||||||||||||
| MCMENEMIE, Jimmy | Geschäftsführer | Logierait Inn PH9 0LJ Logierait Perthshire | Scotland | British | 153129600001 | |||||||||||||
| ORR, Gillean Mcneill | Geschäftsführer | Ballinduin Strathtay PH9 0LP Pitlochry Perthshire | Scotland | British | 18952860001 | |||||||||||||
| ROBERTSON, John Duncan | Geschäftsführer | Middleton Logierait PH9 0LH Pitlochry Perthshire | Scotland | British | 58929780001 | |||||||||||||
| SMITH, Kirsty Cecelia Lupton | Geschäftsführer | 112 Polwarth Gardens EH11 1LH Edinburgh 3f2 Midlothian | Scotland | British | 152701930001 | |||||||||||||
| SMITH, Robert Lupton | Geschäftsführer | Charleston Dalguise PH8 0JX Dunkeld Perthshire | British | 40252280001 | ||||||||||||||
| SMITH, Robert Lupton | Geschäftsführer | Charleston Dalguise PH8 0JX Dunkeld Perthshire | British | 40252280001 | ||||||||||||||
| SOUTAR, William Ross Stewart | Geschäftsführer | Silverburn Strathtay PH9 0PZ Pitlochry Perthshire | British | 64499130001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 23. Mai 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0