LOGIERAIT BRIDGE COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOGIERAIT BRIDGE COMPANY
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited'
    Unternehmensnummer SC151036
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    51 Atholl Road
    Pitlochry
    PH16 5BU Perthshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am11. Okt. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am11. Juli 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis11. Okt. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis23. Mai 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung06. Juni 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis23. Mai 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von J & H Mitchell Ws als Sekretär am 30. Nov. 2024

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2023

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von John Philip Chetwynd Fry als Geschäftsführer am 06. März 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2022

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jimmy Mcmenemie als Geschäftsführer am 26. Juni 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Stanley Bruce als Geschäftsführer am 23. Jan. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Norman David Mccandlish als Geschäftsführer am 27. Juni 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2021

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Philip Chetwynd Fry am 31. Mai 2022

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2020

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Sekretärs für J & H Mitchell Ws am 31. Dez. 2020

    1 SeitenCH04

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2019

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Charles Gordon Dilworth als Geschäftsführer am 22. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr George Anthony Wilson als Direktor am 22. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Dr Anthony Burgess als Direktor am 25. Okt. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Dr Keith Peter Mark Grant als Direktor am 07. Aug. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Donald John Maclean als Direktor am 23. Apr. 2018

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRIDGES, Clive William
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Highfield
    Scotland
    Geschäftsführer
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Highfield
    Scotland
    United KingdomBritishSelf Employed Service Station Owner98399230001
    BURGESS, Anthony, Dr
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Balnamuir House
    Perth And Kinross
    Scotland
    Geschäftsführer
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Balnamuir House
    Perth And Kinross
    Scotland
    ScotlandBritishNone255185130001
    GRANT, Keith Peter Mark, Dr
    Larchwood Road
    PH16 5AS Pitlochry
    Corrour
    Scotland
    Geschäftsführer
    Larchwood Road
    PH16 5AS Pitlochry
    Corrour
    Scotland
    ScotlandBritishRetired Doctor251816320001
    GRANT, Sandra Jane
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Torbeag
    Perthshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Torbeag
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandBritishEstate Office Manager188228180002
    HOWIE, Kathleen Marion
    Ballinluig
    PH9 0LW By Pitlochry
    Tulloch Of Pitnacree
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Ballinluig
    PH9 0LW By Pitlochry
    Tulloch Of Pitnacree
    Perthshire
    ScotlandBritishRetired129849530002
    MACLEAN, Donald John
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Upper Woodinch
    Parth And Kinross
    Geschäftsführer
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Upper Woodinch
    Parth And Kinross
    ScotlandBritishConsultant Chartered Civil Engineer249109650001
    SWINNEY, John Ramsay
    Church Road
    Woodside
    PH13 9QB Blairgowrie
    Lyngrove
    Perthshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Church Road
    Woodside
    PH13 9QB Blairgowrie
    Lyngrove
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandScottishMember Of Scottish Parliament207387880001
    WILSON, George Anthony
    Balnamuir
    Balnaguard
    PH9 0PZ Pitlochry
    The Old Toll House
    Perth And Kinross
    Scotland
    Geschäftsführer
    Balnamuir
    Balnaguard
    PH9 0PZ Pitlochry
    The Old Toll House
    Perth And Kinross
    Scotland
    ScotlandBritishRetired264155410001
    DE MAIME BEAUMONT, Deryck
    Balnaguard Inn
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    Sekretär
    Balnaguard Inn
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    BritishSolicitor35742300001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    J & H MITCHELL WS
    Atholl Road
    PH16 5BU Pitlochry
    51
    Perthshire
    Scotland
    Sekretär
    Atholl Road
    PH16 5BU Pitlochry
    51
    Perthshire
    Scotland
    RechtsformLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    RechtsgrundlageLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    RegistrierungsnummerSO303818
    926840001
    ALSTON, Elizabeth Margaret
    Woodinch
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Woodinch
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Perthshire
    BritishCompany Director40252410001
    BINNER, Laura Christine
    51 Atholl Road
    Pitlochry
    PH16 5BU Perthshire
    Geschäftsführer
    51 Atholl Road
    Pitlochry
    PH16 5BU Perthshire
    ScotlandBritishEvent Management170983540001
    BRADLEY, Patrick Joseph
    Upper Farrochil
    PH15 2EX Aberfeldy
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Upper Farrochil
    PH15 2EX Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritishAccountant55613930001
    BRIDGES, Clive William
    Highfield
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Highfield
    Ballinluig
    PH9 0LG Pitlochry
    Perthshire
    United KingdomBritishFilling Station/Restaurant Pro98399230001
    BRUCE, Stanley
    Rosebank
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Rosebank
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritishRetired90876490001
    DE MAIME BEAUMONT, Deryck
    Balnaguard Inn
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Balnaguard Inn
    Balnaguard
    PH9 0PY Pitlochry
    Perthshire
    BritishSolicitor35742300001
    DILWORTH, Charles Gordon
    Moulin
    PH16 5EL Pitlochry
    Baledmund Road
    Perthshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Moulin
    PH16 5EL Pitlochry
    Baledmund Road
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandScottishRetired129849500001
    FRY, John Philip Chetwynd
    Tulloch Of Pitnacree
    PH9 0LW Pitlochry
    Tulloch Schoolhouse
    Scotland
    Geschäftsführer
    Tulloch Of Pitnacree
    PH9 0LW Pitlochry
    Tulloch Schoolhouse
    Scotland
    ScotlandBritishRetired161055580002
    GILLESPIE, Iain Machray
    Kirkwood
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Kirkwood
    Dalguise
    PH8 0JU Dunkeld
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director481020001
    GRANT, Wilma Alison
    Balnamuir House
    Balnaguard
    PH9 0PZ By Pitlochry
    Geschäftsführer
    Balnamuir House
    Balnaguard
    PH9 0PZ By Pitlochry
    BritishSelf Employed110112250001
    GUINAN, Peter Howard
    Mill Of Logierait
    Logierait
    PH9 0LH Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Mill Of Logierait
    Logierait
    PH9 0LH Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritishFarmer105658740001
    HARVEY, Ian Bruce
    The Steading
    Dalnabo
    PH9 0NL Ballinluig
    Perthshire
    Geschäftsführer
    The Steading
    Dalnabo
    PH9 0NL Ballinluig
    Perthshire
    BritishRetired98967260001
    MABBOTT, Stephen
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Strathclyde
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Strathclyde
    British900007110001
    MCCANDLISH, Eileen Marion
    Knockintober
    Ballinluig
    PH9 0LN Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Knockintober
    Ballinluig
    PH9 0LN Pitlochry
    Perthshire
    BritishRetired70774950001
    MCCANDLISH, Norman David
    Kenmore Street
    PH15 2BL Aberfeldy
    8
    Scotland
    Geschäftsführer
    Kenmore Street
    PH15 2BL Aberfeldy
    8
    Scotland
    ScotlandBritishRetired58107230002
    MCMENEMIE, Jimmy
    Logierait Inn
    PH9 0LJ Logierait
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Logierait Inn
    PH9 0LJ Logierait
    Perthshire
    ScotlandBritishHotelier153129600001
    ORR, Gillean Mcneill
    Ballinduin
    Strathtay
    PH9 0LP Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Ballinduin
    Strathtay
    PH9 0LP Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritishRetired18952860001
    ROBERTSON, John Duncan
    Middleton
    Logierait
    PH9 0LH Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Middleton
    Logierait
    PH9 0LH Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritishFarmer58929780001
    SMITH, Kirsty Cecelia Lupton
    112 Polwarth Gardens
    EH11 1LH Edinburgh
    3f2
    Midlothian
    Geschäftsführer
    112 Polwarth Gardens
    EH11 1LH Edinburgh
    3f2
    Midlothian
    ScotlandBritishIs Project Manager152701930001
    SMITH, Robert Lupton
    Charleston
    Dalguise
    PH8 0JX Dunkeld
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Charleston
    Dalguise
    PH8 0JX Dunkeld
    Perthshire
    BritishRetired40252280001
    SMITH, Robert Lupton
    Charleston
    Dalguise
    PH8 0JX Dunkeld
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Charleston
    Dalguise
    PH8 0JX Dunkeld
    Perthshire
    BritishChartered Surveyor40252280001
    SOUTAR, William Ross Stewart
    Silverburn
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Silverburn
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Perthshire
    BritishRetired Civil Servant64499130001
    SOUTAR, William Ross Stewart
    Silverburn
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Silverburn
    Strathtay
    PH9 0PZ Pitlochry
    Perthshire
    BritishRetired Civil Servant64499130001
    STEUART FOTHRINGHAM, Henry
    The Lagg
    PH15 2EE Aberfeldy
    Perthshire
    Geschäftsführer
    The Lagg
    PH15 2EE Aberfeldy
    Perthshire
    BritishResearcher43515670002

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    23. Mai 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0