LOGIERAIT BRIDGE COMPANY
Überblick
Unternehmensname | LOGIERAIT BRIDGE COMPANY |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
Unternehmensnummer | SC151036 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 51 Atholl Road Pitlochry PH16 5BU Perthshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 11. Okt. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 11. Juli 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Okt. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 06. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von J & H Mitchell Ws als Sekretär am 30. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Philip Chetwynd Fry als Geschäftsführer am 06. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Jimmy Mcmenemie als Geschäftsführer am 26. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stanley Bruce als Geschäftsführer am 23. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Norman David Mccandlish als Geschäftsführer am 27. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Philip Chetwynd Fry am 31. Mai 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für J & H Mitchell Ws am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charles Gordon Dilworth als Geschäftsführer am 22. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr George Anthony Wilson als Direktor am 22. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 11. Okt. 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Dr Anthony Burgess als Direktor am 25. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Dr Keith Peter Mark Grant als Direktor am 07. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Donald John Maclean als Direktor am 23. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGES, Clive William | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Highfield Scotland | United Kingdom | British | Self Employed Service Station Owner | 98399230001 | ||||||||||||
BURGESS, Anthony, Dr | Geschäftsführer | Strathtay PH9 0PZ Pitlochry Balnamuir House Perth And Kinross Scotland | Scotland | British | None | 255185130001 | ||||||||||||
GRANT, Keith Peter Mark, Dr | Geschäftsführer | Larchwood Road PH16 5AS Pitlochry Corrour Scotland | Scotland | British | Retired Doctor | 251816320001 | ||||||||||||
GRANT, Sandra Jane | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Torbeag Perthshire Scotland | Scotland | British | Estate Office Manager | 188228180002 | ||||||||||||
HOWIE, Kathleen Marion | Geschäftsführer | Ballinluig PH9 0LW By Pitlochry Tulloch Of Pitnacree Perthshire | Scotland | British | Retired | 129849530002 | ||||||||||||
MACLEAN, Donald John | Geschäftsführer | Dalguise PH8 0JU Dunkeld Upper Woodinch Parth And Kinross | Scotland | British | Consultant Chartered Civil Engineer | 249109650001 | ||||||||||||
SWINNEY, John Ramsay | Geschäftsführer | Church Road Woodside PH13 9QB Blairgowrie Lyngrove Perthshire Scotland | Scotland | Scottish | Member Of Scottish Parliament | 207387880001 | ||||||||||||
WILSON, George Anthony | Geschäftsführer | Balnamuir Balnaguard PH9 0PZ Pitlochry The Old Toll House Perth And Kinross Scotland | Scotland | British | Retired | 264155410001 | ||||||||||||
DE MAIME BEAUMONT, Deryck | Sekretär | Balnaguard Inn Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | British | Solicitor | 35742300001 | |||||||||||||
REID, Brian | Bevollmächtigter Sekretär | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||||||||||
J & H MITCHELL WS | Sekretär | Atholl Road PH16 5BU Pitlochry 51 Perthshire Scotland |
| 926840001 | ||||||||||||||
ALSTON, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | Woodinch Dalguise PH8 0JU Dunkeld Perthshire | British | Company Director | 40252410001 | |||||||||||||
BINNER, Laura Christine | Geschäftsführer | 51 Atholl Road Pitlochry PH16 5BU Perthshire | Scotland | British | Event Management | 170983540001 | ||||||||||||
BRADLEY, Patrick Joseph | Geschäftsführer | Upper Farrochil PH15 2EX Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | Accountant | 55613930001 | ||||||||||||
BRIDGES, Clive William | Geschäftsführer | Highfield Ballinluig PH9 0LG Pitlochry Perthshire | United Kingdom | British | Filling Station/Restaurant Pro | 98399230001 | ||||||||||||
BRUCE, Stanley | Geschäftsführer | Rosebank Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | Scotland | British | Retired | 90876490001 | ||||||||||||
DE MAIME BEAUMONT, Deryck | Geschäftsführer | Balnaguard Inn Balnaguard PH9 0PY Pitlochry Perthshire | British | Solicitor | 35742300001 | |||||||||||||
DILWORTH, Charles Gordon | Geschäftsführer | Moulin PH16 5EL Pitlochry Baledmund Road Perthshire Scotland | Scotland | Scottish | Retired | 129849500001 | ||||||||||||
FRY, John Philip Chetwynd | Geschäftsführer | Tulloch Of Pitnacree PH9 0LW Pitlochry Tulloch Schoolhouse Scotland | Scotland | British | Retired | 161055580002 | ||||||||||||
GILLESPIE, Iain Machray | Geschäftsführer | Kirkwood Dalguise PH8 0JU Dunkeld Perthshire | Scotland | British | Company Director | 481020001 | ||||||||||||
GRANT, Wilma Alison | Geschäftsführer | Balnamuir House Balnaguard PH9 0PZ By Pitlochry | British | Self Employed | 110112250001 | |||||||||||||
GUINAN, Peter Howard | Geschäftsführer | Mill Of Logierait Logierait PH9 0LH Pitlochry Perthshire | Scotland | British | Farmer | 105658740001 | ||||||||||||
HARVEY, Ian Bruce | Geschäftsführer | The Steading Dalnabo PH9 0NL Ballinluig Perthshire | British | Retired | 98967260001 | |||||||||||||
MABBOTT, Stephen | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow Strathclyde | British | 900007110001 | ||||||||||||||
MCCANDLISH, Eileen Marion | Geschäftsführer | Knockintober Ballinluig PH9 0LN Pitlochry Perthshire | British | Retired | 70774950001 | |||||||||||||
MCCANDLISH, Norman David | Geschäftsführer | Kenmore Street PH15 2BL Aberfeldy 8 Scotland | Scotland | British | Retired | 58107230002 | ||||||||||||
MCMENEMIE, Jimmy | Geschäftsführer | Logierait Inn PH9 0LJ Logierait Perthshire | Scotland | British | Hotelier | 153129600001 | ||||||||||||
ORR, Gillean Mcneill | Geschäftsführer | Ballinduin Strathtay PH9 0LP Pitlochry Perthshire | Scotland | British | Retired | 18952860001 | ||||||||||||
ROBERTSON, John Duncan | Geschäftsführer | Middleton Logierait PH9 0LH Pitlochry Perthshire | Scotland | British | Farmer | 58929780001 | ||||||||||||
SMITH, Kirsty Cecelia Lupton | Geschäftsführer | 112 Polwarth Gardens EH11 1LH Edinburgh 3f2 Midlothian | Scotland | British | Is Project Manager | 152701930001 | ||||||||||||
SMITH, Robert Lupton | Geschäftsführer | Charleston Dalguise PH8 0JX Dunkeld Perthshire | British | Retired | 40252280001 | |||||||||||||
SMITH, Robert Lupton | Geschäftsführer | Charleston Dalguise PH8 0JX Dunkeld Perthshire | British | Chartered Surveyor | 40252280001 | |||||||||||||
SOUTAR, William Ross Stewart | Geschäftsführer | Silverburn Strathtay PH9 0PZ Pitlochry Perthshire | British | Retired Civil Servant | 64499130001 | |||||||||||||
SOUTAR, William Ross Stewart | Geschäftsführer | Silverburn Strathtay PH9 0PZ Pitlochry Perthshire | British | Retired Civil Servant | 64499130001 | |||||||||||||
STEUART FOTHRINGHAM, Henry | Geschäftsführer | The Lagg PH15 2EE Aberfeldy Perthshire | British | Researcher | 43515670002 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LOGIERAIT BRIDGE COMPANY?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
23. Mai 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0