MCSENCE WORKSPACE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMCSENCE WORKSPACE LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC193543
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MCSENCE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED17. Feb. 199917. Feb. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis17. Feb. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung03. März 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis17. Feb. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2025

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2024

    25 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Theresa Morrison als Direktor am 28. Aug. 2024

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christopher George Frederick Olley als Direktor am 27. Feb. 2024

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023

    25 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Dogan Denli als Geschäftsführer am 18. Juni 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr John Paterson als Direktor am 14. Jan. 2023

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    24 SeitenAA

    Ernennung von Mr Dogan Denli als Direktor am 31. Mai 2022

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Anne Ct Mcdonald als Geschäftsführer am 17. Dez. 2021

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Barry Cassells als Direktor am 15. Jan. 2022

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2021

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Mcsence Ltd as a person with significant control on 28. Apr. 2021

    2 SeitenPSC02

    Withdrawal of a person with significant control statement on 28. Apr. 2021

    2 SeitenPSC09

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2020

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Sharon Margaret Hill als Direktor am 30. Nov. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Harris als Geschäftsführer am 30. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PATERSON, Scott
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Sekretär
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    167178660001
    CASSELLS, Barry
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish292762410001
    HILL, Sharon Margaret
    32 Sycamore Road
    Mayfield
    EH22 5TA Dalkeith
    32
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    32 Sycamore Road
    Mayfield
    EH22 5TA Dalkeith
    32
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandScottish97910600002
    HOGG, Michael
    Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5EQ Dalkeith
    43h
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5EQ Dalkeith
    43h
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish68724210002
    HOGG, Robert
    44 Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5DZ Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    44 Bogwood Road
    Mayfield
    EH22 5DZ Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish46111230003
    MORRISON, Theresa
    Waverley Street
    Mayfield
    EH22 5SE Dalkeith
    30
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Waverley Street
    Mayfield
    EH22 5SE Dalkeith
    30
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish327632030001
    OLLEY, Christopher George Frederick
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish320686990001
    PATERSON, John
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish306320960001
    PATERSON, Scott
    80 Denholm Avenue
    EH21 6TY Musselburgh
    East Lothian
    Geschäftsführer
    80 Denholm Avenue
    EH21 6TY Musselburgh
    East Lothian
    United KingdomBritish126689700001
    RAMSAY, Barbara
    30 Leighton Crescent
    Easthouses
    EH22 4DX Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    30 Leighton Crescent
    Easthouses
    EH22 4DX Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish19100140001
    BOWIE, Patricia
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Sekretär
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Scottish46111440001
    CAUSER, Allison
    18 Sherwood View
    EH19 3NQ Bonnyrigg
    Midlothian
    Sekretär
    18 Sherwood View
    EH19 3NQ Bonnyrigg
    Midlothian
    British97433420001
    CRAIG, Julie
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    Sekretär
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    British68971180002
    PATERSON, Alan
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    Sekretär
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    British97442470003
    BOWIE, Patricia
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    54 Larch Crescent
    Mayfield
    EH22 5ND Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish46111440001
    BOYLE, Peter
    57 Waugh Path
    EH19 3QE Bonnyrigg
    Midlothian
    Geschäftsführer
    57 Waugh Path
    EH19 3QE Bonnyrigg
    Midlothian
    British87849850001
    CHRISTISON, Lynda
    4 Rowantree Road
    Mayfield
    EH22 5ER Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    4 Rowantree Road
    Mayfield
    EH22 5ER Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandScottish68724340001
    CRAIG, Julie
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    Geschäftsführer
    3 Hillside Drive
    TD1 2HN Galashiels
    Selkirkshire
    British68971180002
    DENLI, Dogan
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish300094960001
    EDMONDS, David William
    18 Stone Avenue
    Mayfield
    EH22 5PD Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    18 Stone Avenue
    Mayfield
    EH22 5PD Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish62958530001
    GRANT, Terence John
    36 Blackcot Avenue
    Mayfield
    EH22 5RR Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    36 Blackcot Avenue
    Mayfield
    EH22 5RR Dalkeith
    Midlothian
    British68970740002
    HARRIS, Christopher
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish50716750001
    HOGG, James Burns
    20 David Scott Avenue
    EH22 5BU Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    20 David Scott Avenue
    EH22 5BU Dalkeith
    Midlothian
    British87998960001
    MAXWELL, David Caven
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish149458350001
    MCDONALD, Anne Ct
    Thorburn Road
    EH13 0BQ Edinburgh
    26
    Scotland
    Geschäftsführer
    Thorburn Road
    EH13 0BQ Edinburgh
    26
    Scotland
    ScotlandBritish203747900001
    MORELAND, Colin Beattie
    Hillview Terrace
    EH12 8RA Edinburgh
    3
    Scotland
    Geschäftsführer
    Hillview Terrace
    EH12 8RA Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish102920570001
    MORELAND, Colin Beattie
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish102920570001
    MORRISON, Kevin
    Campview
    EH22 1QB Danderhall
    28
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    Campview
    EH22 1QB Danderhall
    28
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish203747840001
    MURPHY, James
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish101169690001
    ONEILL, Patrick
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    41 Darcy Road
    Mayfield
    EH22 5HL Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish19100080001
    PATERSON, Alan
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    Geschäftsführer
    32 Castle Avenue
    EH32 0ES Port Seton
    United KingdomBritish97442470003
    RODGER, Williamina Shaw
    97 Oak Place
    Mayfield
    EH22 5NB Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    97 Oak Place
    Mayfield
    EH22 5NB Dalkeith
    Midlothian
    United KingdomBritish46111510001
    SHAW, Albert
    15 Blackcot Avenue
    EH22 5RY Mayfield
    Midlothian
    Geschäftsführer
    15 Blackcot Avenue
    EH22 5RY Mayfield
    Midlothian
    United KingdomBritish97433350001
    SHAW, Christopher John
    Glencairn
    13 Waverley Road Eskbank
    EH22 3DG Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Glencairn
    13 Waverley Road Eskbank
    EH22 3DG Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish80086590003
    TANNERHILL, Brian Thomas
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Unit 2, 32 Sycamore Road
    Mcsence Business Enterprise Park
    EH22 5TA Mayfield, Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish159013130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sycamore Road
    Mayfield
    EH22 5TA Dalkeith
    32 Sycamore Road
    Scotland
    28. Apr. 2021
    Sycamore Road
    Mayfield
    EH22 5TA Dalkeith
    32 Sycamore Road
    Scotland
    Nein
    RechtsformCharitable Company Limited By Guarantee
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc129794
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für MCSENCE WORKSPACE LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    17. Feb. 201727. Apr. 2021Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0