OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | SC198792 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 25 Bothwell Street G2 6NL Glasgow Strathclyde |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Bericht über die Schlussversammlung der freiwilligen Liquidation | 3 Seiten | 4.26(Scot) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 410(Scot) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNESS LLP | Sekretär | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| BOYLE, Alan Douglas | Geschäftsführer | 12 Glenbervie Drive FK5 4NP Larbert Stirlingshire | Scotland | British | 98018080001 | |||||
| CORREIA, Maria Theresa | Geschäftsführer | South Park Drive PA2 6JQ Paisley 4 Renfrewshire | British | 130696540001 | ||||||
| HILDEBRAND, Mabel Edith Maud | Geschäftsführer | 54 Ottoline Drive KA10 7AW Troon Ayrshire | British | 40177820001 | ||||||
| HYSLOP, Graeme | Geschäftsführer | 14 Stuart Drive G64 2AS Bishopbriggs Lanarkshire | British | 124364200001 | ||||||
| KELLY, Thomas John | Geschäftsführer | 69 Trinity Road EH5 3HS Edinburgh | United Kingdom | British | 47409190002 | |||||
| MCGUINNESS, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 80 Boylestone Road G78 1JL Barrhead East Renfrewshire | Scotland | British | 60077550003 | |||||
| MULLIGAN, Christine | Geschäftsführer | 8 Carse Terrace FK10 2EB Alloa Clackmannanshire | British | 93497860001 | ||||||
| PATTERSON, Kathleen Ann | Geschäftsführer | 14 Belford Mews EH4 3BT Edinburgh | British | 95500780001 | ||||||
| STEVENSON, David | Geschäftsführer | 1 Braeview Crescent Star KY7 6LZ Kirkcaldy Fife | British | 86302340003 | ||||||
| KELLY, Charles | Sekretär | 10 Fern Cottages G13 1NH Glasgow | British | 78079410001 | ||||||
| KORONKA, Heather Christine | Sekretär | 11 Muirfield Street KY2 6SY Kirkcaldy Fife | British | 65436780002 | ||||||
| BURNESS SOLICITORS | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| ARCHIBALD, Anneliese | Geschäftsführer | 11/3 St Leonards Crag EH8 9SP Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 110653850001 | |||||
| BISSET, Alistair | Geschäftsführer | 3 Fleurs Place IV30 1ST Elgin Morayshire | British | 125254620001 | ||||||
| CHALMERS, David Stuart | Geschäftsführer | 1 Saxe Coburg Street EH3 5BN Edinburgh Midlothian | British | 65436770001 | ||||||
| CHALMERS, David Stuart | Geschäftsführer | 1 Saxe Coburg Street EH3 5BN Edinburgh Midlothian | British | 65436770001 | ||||||
| COLWELL, Adrian Peter | Geschäftsführer | Flat 23 The Maltings 165 Slateford Road EH14 1PD Edinburgh Midlothian | British | 65785300003 | ||||||
| GREEN, Malcolm Robert, Dr | Geschäftsführer | 46 Victoria Crescent Road G12 9DE Glasgow | United Kingdom | British | 1413480001 | |||||
| HILDEBRAND, Mabel Edith Maud | Geschäftsführer | 54 Ottoline Drive KA10 7AW Troon Ayrshire | British | 40177820001 | ||||||
| HORNER, Robert Malcolm Wigglesworth, Professor | Geschäftsführer | 11 Westfield Place DD1 4JU Dundee Angus | Scotland | British | 2803800001 | |||||
| KELLY, Thomas John | Geschäftsführer | 3/1 Caithness Place EH5 3AE Edinburgh | British | 47409190001 | ||||||
| KORONKA, Heather Christine | Geschäftsführer | 11 Muirfield Street KY2 6SY Kirkcaldy Fife | British | 65436780002 | ||||||
| MAY, Christine Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Cairngorm Crescent KY2 5RG Kirkcaldy 27 Fife | Scotland | Irish,British | 51665990001 | |||||
| MORGAN, Angela Rosalie | Geschäftsführer | 34 Whins Road FK10 3RE Alloa Clackmannanshire | United Kingdom | United Kingdom | 73440930002 | |||||
| NICOLL, David | Geschäftsführer | 18 Austen Road G13 1SJ Glasgow | Scotland | British | 78813370001 | |||||
| RAINES, Philip | Geschäftsführer | 325 North Woodside Road G20 6ND Glasgow | British | 90204170001 | ||||||
| SMITH, Deborah | Geschäftsführer | Area 2-H Victoria Quay, Leith EH6 6QQ Edinburgh | British | 76550470001 | ||||||
| SMITH, Linda Anne | Geschäftsführer | 135 Terregles Avenue Pollokshields G41 4DG Glasgow | Scotland | British | 88716300001 | |||||
| THOMAS, Elizabeth | Geschäftsführer | Mansewood Road G43 1BP Glasgow 97 | Scotland | British | 86043760001 | |||||
| WRIGHT, Brian Kenneth | Geschäftsführer | Binniehill Road G68 9AJ Cumbernauld 10 N Lanarkshire | Scotland | British | 128664130001 |
Hat OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Erstellt am 17. Okt. 2008 Geliefert am 23. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OBJECTIVE 3 PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0