GOALS SOCCER CENTRES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGOALS SOCCER CENTRES PLC
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer SC202545
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    • Betrieb von Sportanlagen (93110) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GOALS SOCCER CENTRES LIMITED12. Feb. 200112. Feb. 2001
    FORTIS LEISURE LIMITED14. Jan. 200014. Jan. 2000
    DMWS 389 LIMITED21. Dez. 199921. Dez. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2018
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2019
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis29. Nov. 2019
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung13. Dez. 2019
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis29. Nov. 2018
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht des Administrators

    31 SeitenAM10(Scot)

    Gerichtsbeschluss in einer Liquidation (& Gerichtsbeschluss-Anhang)

    5 SeitenWU01(Scot)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    3 SeitenAM19(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    37 SeitenAM10(Scot)

    Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11(Scot)

    Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    4 SeitenAM16(Scot)

    Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    4 SeitenAM16(Scot)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Teneo Financial Advisory Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ zum C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House Rutland Square Edinburgh EH1 2AA am 02. Nov. 2023

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    3 SeitenAM19(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    20 SeitenAM10(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    20 SeitenAM10(Scot)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    3 SeitenAM19(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    19 SeitenAM10(Scot)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Teneo Restructuring Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ zum C/O Teneo Financial Advisory Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ am 23. Feb. 2022

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    4 SeitenAM19(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    20 SeitenAM10(Scot)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    3 SeitenAM19(Scot)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 West Geogre Street Glasgow G2 1PJ Scotland zum C/O Teneo Restructuring Limited 100 West George Street Glasgow Scotland G2 1PJ am 02. Sept. 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2DB zum 100 West Geogre Street Glasgow G2 1PJ am 28. Juni 2021

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Administrators

    19 SeitenAM10(Scot)

    Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    9 SeitenAM16(Scot)

    Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    16 SeitenAM10(Scot)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    3 SeitenAM19(Scot)

    Fortschrittsbericht des Administrators

    19 SeitenAM10(Scot)

    Wer sind die Geschäftsführer von GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOW, William Berrie Gordon
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Sekretär
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    British74161570001
    PARK, Louise Emily
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Sekretär
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    254376660001
    ROGERS, Keith Taylor
    Over Lethame House
    ML10 6RW Strathaven
    Lanarkshire
    Sekretär
    Over Lethame House
    ML10 6RW Strathaven
    Lanarkshire
    British67066370003
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Bevollmächtigter Sekretär
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    ANSON, Andrew Edward
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishChief Executive245777290001
    BASING, Nicolas Andrew
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishChairman183640000001
    BOLINGBROKE, Michael
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishNon Executive209626860001
    BRUCE, Roderick Lawrence
    Campend Farmhouse
    Campend Farm
    EH22 1RS Dalkeith
    Midlothian
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Campend Farmhouse
    Campend Farm
    EH22 1RS Dalkeith
    Midlothian
    British900018790001
    BURKS, Philip Adrian
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishNon Executove Director146669160001
    EDELMAN, Keith Graeme
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishCompany Director143145410001
    GOW, William Berrie Gordon
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishAccountant74161570001
    HAND, Alan Michael
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandIrishDirector254880700001
    JONES, Mark Vincent
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishChief Executive107650230003
    KIRKPATRICK, Stephen
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritishDirector129442070001
    LLOYD, Scott Anthony
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishCompany Director65590160004
    MIDDLETON, Shaun Norman Skene
    19 Queens Crescent
    EH9 2BB Edinburgh
    Geschäftsführer
    19 Queens Crescent
    EH9 2BB Edinburgh
    United KingdomBritishInvestment Manager72074940002
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    Geschäftsführer
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Saltire Court
    EnglandBritishInvestment Manager201205110001
    MINTO, Bruce Watson
    The Avenue 40 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    The Avenue 40 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor36629160003
    PAYTON, Morris Iain
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director152257760001
    ROGERS, John
    2 Maple Avenue
    Stenhousemuir
    FK5 4BT Larbert
    Stirlingshire
    Geschäftsführer
    2 Maple Avenue
    Stenhousemuir
    FK5 4BT Larbert
    Stirlingshire
    BritishDirector69404460001
    ROGERS, Keith Taylor
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director67066370003
    RONSON, Jacqueline Ann
    Redwood Crescent
    East Kilbride
    G74 5PA Glasgow
    Goals Soccer Centres Plc
    Scotland
    Geschäftsführer
    Redwood Crescent
    East Kilbride
    G74 5PA Glasgow
    Goals Soccer Centres Plc
    Scotland
    United KingdomBritishDigital, Crm & Insights Director115470920003
    SCOULER, Brian Buchanan
    31 Cramond Road North
    EH4 6LY Edinburgh
    Geschäftsführer
    31 Cramond Road North
    EH4 6LY Edinburgh
    ScotlandBritishInvestment Banker35968050002
    SHORT, Alexander Brian Cooper
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    ScotlandBritishFinance Director91254170004
    WALKER, Rodney Myerscough, Sir
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    EnglandBritishDirector56514100001
    WILSON, Robert Graham
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Orbital House
    Peel Park
    G74 5PA East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector6564660002

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GOALS SOCCER CENTRES PLC?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    29. Nov. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat GOALS SOCCER CENTRES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Nov. 2016
    Geliefert am 06. Dez. 2016
    Ausstehend
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Apr. 2016
    Geliefert am 05. Mai 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Leasehold property known as land at high gosforth park, newcastle upon tyne registered at H.M. land registry under title number TY476459.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Sept. 2014
    Geliefert am 23. Sept. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The golf course land at redcote lane, kirkstall, leeds forming part of the landlord’s freehold title registered at H. M. land registry with absolute title under title number WYK819547, as more particularly described in the lease between (1) ogden waller limited (in administration); (2) k l dukes, I d green & d j kelly; and (3) goals soccer centres PLC.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Sept. 2014
    Geliefert am 23. Sept. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The land at goals soccer centre, redcote lane, kirkstall, leeds forming part of the landlord’s freehold title registered at H. M. land registry with absolute title under title number WYK819547, as more particularly described in the lease between (1) ogden waller limited (in administration); (2) k l dukes, I d green & d j kelly; and (3) goals soccer centres PLC.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Nov. 2013
    Geliefert am 04. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. by way of legal mortgage the leasehold land and buildings at wheatley hall road, doncaster forming part of the landlord's freehold title registered at hm land registry with absolute title under title number SYK446882 and SYK598925 as more particularly described in a lease dated 8 april 2013 between (1) st modwen ventures limited and (2) goals soccer centres PLC and now registered with absolute title under title number SYK607111 ("the property") together with all present and future buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property;. 2. by way of fixed charge any goodwill relating to the property or the business or undertaking conducted at the property;. 3. by way of fixed charge all plant, machinery and other items attached to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge;. 4. by way of assignment the rents, profits, income, fees and other sums at any time payable by any lessees, underlessees, tenants or licensees of the property to the owner pursuant to the terms of any agreements for lease, leases, underleases, tenancies or licences to which all or any part of the property is subject but not any sums payable in respect of services provided to such lessees, underlessees, tenant or licensees or payable in respect of insurance premiums or reasonable professional fees or expenses together with the benefit of all rights and remedies of the borrower relating to them to the bank absolutely subject to redemption upon repayment of the secured liabilities. 5. by way of fixed charge all rights and interests in and claims made under any insurance policy relating to any of the property charged under the charge; and. 6. by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods now or at any time after the date of the charge on or in or used in connection with the property or the business or undertaking conducted and the property. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Okt. 2013
    Geliefert am 18. Okt. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Okt. 2013
    Geliefert am 18. Okt. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 2013
    Geliefert am 21. Feb. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold land and buildings known as land at queens road cheetham hill manchester GM934832.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2013Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Mai 2012
    Geliefert am 05. Mai 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Chester commerce park bumpers lane chester CH555723.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2012
    Geliefert am 21. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as land and buildings at durham road sunderland tyne & wear.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 2012
    Geliefert am 07. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold land and premises at rope walk ipswich suffolk SK240769.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over land and buildings at crown hill community college, gwendolen road, leicester LT439826.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Okt. 2011
    Geliefert am 18. Okt. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Land and buildings at crown hill community college gwendolen road leicester LT3998370.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Sept. 2011
    Geliefert am 14. Sept. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Land at abbeyfields school, northampton.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 2011
    Geliefert am 13. Aug. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as tangiers road portsmouth 1) portsmouth college and 2)goals soccer centres PLC PM16644.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Standard security
    Erstellt am 02. Mai 2011
    Geliefert am 17. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Premises forming all and whole the area of ground to the north of great southern road aberdeen knc 21413.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2011
    Geliefert am 07. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold land known as hewett school cecil road norwich NK402587.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2011
    Geliefert am 26. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold land and buildings at site a ipark innovation road hull.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 2010
    Geliefert am 20. Nov. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Land and buildings at syon lane, osterley.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Okt. 2010
    Geliefert am 06. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Bushey middle school playing fields beverley way west wimbledon london.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 2010
    Geliefert am 05. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as land on the north side of speke boulevard liverpool MS575526.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juli 2010
    Geliefert am 03. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as land and buildings on the south side of ironmould lane brislington BL110763.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2010
    Geliefert am 16. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as land situate at hanson school sutton avenue bradford.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2009
    Geliefert am 08. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Premises at granville road sheffield.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01s)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Okt. 2009
    Geliefert am 16. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Land at bulmershe school, woodley.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01s)

    Hat GOALS SOCCER CENTRES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Okt. 2019Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gavin George Scott Park
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Praktiker
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Robert James Harding
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praktiker
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Michael John Magnay
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praktiker
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Stephen Hunt
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Praktiker
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    2
    DatumTyp
    13. Juni 2024Antragsdatum
    13. Juni 2024Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Hunt
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Praktiker
    Griffins, Tavistock House North Tavistock Square
    WC1H 9HR London
    Anmerkungenscottish-insolvency-info

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0