EPILEPSY CONNECTIONS
Überblick
Unternehmensname | EPILEPSY CONNECTIONS |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
Unternehmensnummer | SC212813 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EPILEPSY CONNECTIONS?
- Sonstige Bildung n.n.g. (85590) / Erziehung
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
- Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich EPILEPSY CONNECTIONS?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suites 129 - 134 Baltic Chambers 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Scotland |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPILEPSY CONNECTIONS?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2025 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für EPILEPSY CONNECTIONS?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 26. Sept. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 10. Okt. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 26. Sept. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für EPILEPSY CONNECTIONS?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2024 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Hugh Robinson als Direktor am 19. Juni 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Dr Maytal Wolfe als Direktor am 06. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Rachel Antonia Edwards as a person with significant control on 12. Feb. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Meritxell Maria Oto als Geschäftsführer am 19. Feb. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rachel Antonia Edwards als Geschäftsführer am 19. Feb. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2023 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Fraser Bruce als Geschäftsführer am 16. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Lindsay als Geschäftsführer am 26. Juli 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 18 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2022 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2021 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Mr Conor Kerr as a person with significant control on 17. Feb. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lorna Jayne Forrest als Direktor am 09. Dez. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Notification of Conor Kerr as a person with significant control on 09. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Conor Kerr am 30. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Conor Kerr am 18. Dez. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Doctor Meritxell Maria Oto am 18. Dez. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EPILEPSY CONNECTIONS?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADLEY, John Russell | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British | Solicitor | 172486260002 | ||||
FORREST, Lorna Jayne | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | Scottish | Head Of Service Delivery, Scvo | 277816420001 | ||||
KERR, Conor | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British | Accountant | 262201030002 | ||||
MCGHEE, Susan Jane | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British | Operations Director | 253577700001 | ||||
NIXON, Brian Clarke | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British | Chartered Engineer / Consultant | 229386850001 | ||||
ROBINSON, Philip Hugh, Dr | Geschäftsführer | Broomberry Drive PA19 1JY Gourock 36 Scotland | Scotland | British | Retired Social Worker | 100269280001 | ||||
WOLFE, Maytal, Dr | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | United Kingdom | British | Consultant Liaison Psychiatrist | 322210430001 | ||||
BYRNE, Vincent James, Rev | Sekretär | St Patricks Orangefield Place PA15 1YX Greenock | British | 72825070002 | ||||||
COCHRANE, Judy | Sekretär | Well Road Kilbarchan PA10 2LZ Johnstone Cochrane Cottage Renfrewshire Scotland | 191546160001 | |||||||
MCNULTY, Dorothy Scott | Sekretär | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | British | Admin Co-Orinator | 101472000001 | |||||
ALCOCK, Jean Margaret Diack | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Sole Trader | 82735630002 | ||||
BEDWELL, Gillian | Geschäftsführer | c/o Epilepsy Connections Wellington Street G2 6DH Glasgow 100 Scotland | Scotland | British | Paediatric Occupational Therapist | 150144300002 | ||||
BRUCE, John Fraser | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British | Unemployed | 240597460001 | ||||
BYRNE, Vincent James, Reverend | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | United Kingdom | British | Catholic Priest | 72825070004 | ||||
COCHRANE, Judy | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Retired | 91864050002 | ||||
CRUICKSHANKS, Fiona | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Personal Assistant | 94954370002 | ||||
DICKSON, Ian | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Retired | 153780002 | ||||
EDWARDS, Rachel Antonia | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | Scottish | Marketing And Events Manager | 206097290001 | ||||
GORMAN-BELL, Margaret | Geschäftsführer | St Brydes Kilbryde Crescent FK15 9BB Dunblane Perthshire | Scotland | British | Business Consultant | 72825040002 | ||||
GUTHRIE, Eleanor, Dr | Geschäftsführer | 28 Austen Road G13 1SJ Glasgow Lanarkshire | British | General Practitioner | 26492780001 | |||||
HANNAH, Jean Ann, Dr | Geschäftsführer | c/o Epilepsy Connections Wellington Street G2 6DH Glasgow 100 Scotland | Scotland | British | General Practitioner | 150309710001 | ||||
LINDSAY, Andrew, Mr. | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Scotland | British,French | Public Affairs Professional | 216171910001 | ||||
MCGARVEY, Christine Campbell | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Retired | 136932590001 | ||||
OTO, Meritxell Maria, Doctor | Geschäftsführer | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | United Kingdom | Spanish | Consultant Neuropsychiatrist | 198255660001 | ||||
PARKER, Pamela Grace | Geschäftsführer | 100 Wellington Street G2 6DH Glasgow Epilepsy Connections Scotland | Scotland | British | Nurse | 129518380002 | ||||
PENRICE, Gillian, Dr | Geschäftsführer | 1 Hughenden Drive G12 9XS Glasgow Lanarkshire | British | Medical Practitioner | 72825050001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EPILEPSY CONNECTIONS?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Conor Kerr | 09. Sept. 2019 | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Ms Rachel Antonia Edwards | 14. Aug. 2019 | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Ja |
Nationalität: Scottish Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Susan Jane Mcghee | 14. Aug. 2019 | 50 Wellington Street G2 6HJ Glasgow Suites 129 - 134 Baltic Chambers Scotland | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Pamela Grace Parker | 05. Juli 2017 | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB Lanarkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Jean Margaret Diack Alcock | 05. Juli 2017 | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB Lanarkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Ian Dickson | 29. Juni 2016 | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB Lanarkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Christine Campbell Mcgarvey | 29. Juni 2016 | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB Lanarkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Judith Cochrane | 29. Juni 2016 | 109 Douglas Street Glasgow G2 4HB Lanarkshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0