COLERIDGE (NO.8) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOLERIDGE (NO.8) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC232124
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COLERIDGE (NO.8) LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich COLERIDGE (NO.8) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COLERIDGE (NO.8) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für COLERIDGE (NO.8) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Bericht über die Schlussversammlung der freiwilligen Liquidation

    44 Seiten4.26(Scot)

    Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 22. März 2016

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Claire Treacy als Geschäftsführer am 05. Jan. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Neil Kenneth Robertson als Direktor am 05. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Fraser James Kennedy als Geschäftsführer am 14. Aug. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Claire Treacy als Direktor am 14. Aug. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    24 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    23 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von COLERIDGE (NO.8) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Sekretär
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300002
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    British900023700001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Sekretär
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    British900023690001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    FOWLIE, Frank Alexander
    Flat 1/2, 18 Woodburn Terrace
    EH10 4SH Edinburgh
    Geschäftsführer
    Flat 1/2, 18 Woodburn Terrace
    EH10 4SH Edinburgh
    BritishSolicitor81464680001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishSurveyor109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AG Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AG Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker106197810002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Geschäftsführer
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Geschäftsführer
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishDirector69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishHead Of Tax & Risk, Europe189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Hat COLERIDGE (NO.8) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Share pledge
    Erstellt am 23. März 2012
    Geliefert am 29. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 25. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Bond & floating charge
    Erstellt am 23. März 2012
    Geliefert am 29. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 03. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the security assets as security for the secured sums. (Please see form).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 03. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the security assets as security for the secured sums please see form.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 02. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01s)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 07. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 07. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the units and related rights (security assets).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Accession agreement and charge
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 04. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Share pledge
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 04. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in the existing shares and the related rights.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (410)
    • 25. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 18. Juni 2003
    Geliefert am 28. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over all the freehold property known as land at 110-113 tottenham court road, london (title number 226325); fixed and floating charges over assets.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juni 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 23. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 10. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    The market place, high street, blackwood, gwent. See ch microfiche for full details.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 07. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the property known as land at arundel court, furnival street, sheffield, south yorkshire--title number SYK439410; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 15. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the property known as 147-149 london road, east grinstead--title number WSX18176; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 21. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the property known as 2010 meriden business park, birmingham road, allesley, coventry; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the property known as 49/53 london street, reading--title number BK253666; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the land known as 27 & 29 cathedral road, cardiff--title numbers WA959576 and WA959577; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (410)
    • 14. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 01. Nov. 2002
    Geliefert am 11. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over property known as 38 stepney street, llanelli; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 16. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the freehold property known as 130 and 132 above bar street, southampton; fixed and floating charges over assets.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 28. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Floating charge
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 12. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 110-113 tottenham court road, london; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 23. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at arundel court, furnival street, sheffield, south yorkshire; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 15. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 2010 meriden business park, birmingham road, allesley, coventry; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 49/53 london street, reading; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in the land and buildings at 147 and 149 london road, east grinstead; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 21. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)
    Charge over contract for sale
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at market place, blackwood, gwent; first fixed charge over assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (410)
    • 07. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (419a)

    Hat COLERIDGE (NO.8) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. März 2016Beginn der Liquidation
    24. Juli 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anmerkungenscottish-insolvency-info

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0