KELTNEYBURN HYDRO LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKELTNEYBURN HYDRO LTD
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC237428
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    • Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
    • Handel mit Elektrizität (35140) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft

    Wo befindet sich KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cef Building Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SIMEC GHR KELTNEYBURN HYDRO LIMITED17. Juli 201817. Juli 2018
    KELTNEYBURN HYDRO LIMITED27. Sept. 200227. Sept. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis27. Sept. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung11. Okt. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis27. Sept. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    9 SeitenAA

    legacy

    40 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jemma Louise Sherman als Geschäftsführer am 10. Jan. 2025

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Thomas Samuel Cunningham als Direktor am 10. Jan. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Sydney Geraint Blackmore als Geschäftsführer am 07. Nov. 2024

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Marco Panfili als Direktor am 07. Nov. 2024

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Marco Panfili als Geschäftsführer am 02. Apr. 2024

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Sydney Geraint Blackmore als Direktor am 02. Apr. 2024

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Jemma Louise Sherman am 03. Apr. 2024

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Marco Panfili als Direktor am 01. März 2024

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Benjamin Michael Burgess als Geschäftsführer am 01. März 2024

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Jemma Louise Sherman am 17. Nov. 2022

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Nathan John Wakefield als Geschäftsführer am 13. Feb. 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Simon David Green als Geschäftsführer am 27. Mai 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Jemma Louise Sherman als Direktor am 27. Mai 2022

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Ben Burgess am 16. Dez. 2021

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CUNNINGHAM, Thomas Samuel
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish211537780001
    PANFILI, Marco
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ItalyItalian329508350001
    J & H MITCHELL WS
    Atholl Road
    PH16 5BU Pitlochry
    51
    Perthshire
    Scotland
    Sekretär
    Atholl Road
    PH16 5BU Pitlochry
    51
    Perthshire
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerN/A
    926840001
    ALLAN, Peter Philip Charles
    35 Craigleith View
    EH4 3JY Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    35 Craigleith View
    EH4 3JY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish66870590002
    BLACKMORE, Sydney Geraint
    South Building
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Building
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomWelsh312246730001
    BURGESS, Benjamin Michael
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish290811840013
    CARTHWRIGHT, Ian Peter George
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish260931700001
    CARTWRIGHT, Ian Peter George
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish48267100001
    CARTWRIGHT, Ian Peter George
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish48267100001
    GANDHI, Rajeev
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    WalesIndian237228900001
    GREEN, Simon David
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish164987040001
    GREEN, Simon David
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish164987040001
    GUPTA, Parduman Kumar
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    IndiaIndian249067140001
    HAMBRO, Jay
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish245504790001
    HENDERSON, Alistair
    Wester Carse
    PH15 2NB Aberfeldy
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Wester Carse
    PH15 2NB Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish354270001
    HOGG, David
    38 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    Geschäftsführer
    38 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    ScotlandBritish40769390002
    HUTT, Stephen Mark
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish260925030001
    PANFILI, Marco
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ItalyItalian320047140001
    READING, Alexander James
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish183403880001
    READING, Alexander James
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish183403880001
    READING, Alexander James
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    ScotlandBritish183403880001
    SHERMAN, Jemma Louise
    South Building
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    South Building
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish275435530004
    STEWART, Donald Gordon William
    Greenend 17 Balfron Road
    Killearn
    G63 9NN Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Greenend 17 Balfron Road
    Killearn
    G63 9NN Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish39839930002
    STEWART, James
    Milndavie Road
    Strathblane
    G63 9EW Glasgow
    An Larach
    Geschäftsführer
    Milndavie Road
    Strathblane
    G63 9EW Glasgow
    An Larach
    ScotlandBritish138127720001
    STEWART, Thomas James Bunting
    Keltney House
    Keltneyburn
    PH15 2LF Aberfeldy
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Keltney House
    Keltneyburn
    PH15 2LF Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish84588240001
    TRAINER, Christopher David
    Dalziel Drive
    Pollokshields
    G41 4NY Glasgow
    50
    Scotland
    Geschäftsführer
    Dalziel Drive
    Pollokshields
    G41 4NY Glasgow
    50
    Scotland
    ScotlandBritish249930005
    VONDRAKOVA, Kveta
    Regent Street
    W1B 2HA London
    1st Floor Roxburghe House
    England
    Geschäftsführer
    Regent Street
    W1B 2HA London
    1st Floor Roxburghe House
    England
    Czech RepublicCzech252190150001
    WAKEFIELD, Nathan John
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish314504440001
    WAKEFIELD, Nathan John
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    Cef Building
    Scotland
    United KingdomBritish314504440001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KELTNEYBURN HYDRO LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ghh Group Holdings Ltd
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    1st Floor Cef Building
    Scotland
    08. Juli 2019
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    1st Floor Cef Building
    Scotland
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Vk Hypropower Ltd
    Roxburghe House
    273/287 Regent Street
    W1B 2HA London
    1st Floor
    England
    24. Sept. 2018
    Roxburghe House
    273/287 Regent Street
    W1B 2HA London
    1st Floor
    England
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer11541953
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Green Highland Hydro Ltd
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    First Floot Cef Building
    Scotland
    12. Aug. 2016
    Inveralmond Road
    Inveralmond Industrial Estate
    PH1 3TW Perth
    First Floot Cef Building
    Scotland
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0