VOLUNTARY ACTION ANGUS

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVOLUNTARY ACTION ANGUS
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited'
    Unternehmensnummer SC248473
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    • Bildungsunterstützende Dienstleistungen (85600) / Erziehung

    Wo befindet sich VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Third Sector Centre
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Angus
    Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VOLUNTEER CENTRE ANGUS28. Apr. 200328. Apr. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis28. Apr. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung12. Mai 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis28. Apr. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Scott Marshall als Direktor am 07. Nov. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kenneth White Lee als Geschäftsführer am 22. Aug. 2025

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2025

    35 SeitenAA

    Ernennung von Douglas Walker als Direktor am 09. Mai 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anne Margaret Callander als Geschäftsführer am 25. Juni 2025

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Gail Margaret Smith als Direktor am 09. Apr. 2025

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024

    37 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Rhona Margaret Guild als Geschäftsführer am 28. Nov. 2024

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jill Scott als Geschäftsführer am 28. Nov. 2024

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Sharon Jean Neilson als Geschäftsführer am 15. Aug. 2024

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023

    38 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Jill Scott als Direktor am 28. Apr. 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Rhona Margaret Guild als Direktor am 28. Apr. 2023

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    36 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Anne Robertson Brown als Geschäftsführer am 04. Juli 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Pamela Reid Wardlaw als Geschäftsführer am 04. Juli 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Anne Margaret Callander als Direktor am 28. Apr. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Kenneth White Lee als Direktor am 28. Apr. 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Sharon Jean Neilson als Direktor am 28. Apr. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Robert Prentice als Geschäftsführer am 28. Apr. 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2021

    42 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MEARNS, Hayley
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Sekretär
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    283271610001
    BELL, Julie Alexander
    Kingoldrum
    DD8 5HD Kirriemuir
    Broadmuir Cottage
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    Kingoldrum
    DD8 5HD Kirriemuir
    Broadmuir Cottage
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish246240480001
    MARSHALL, Scott
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish343709770001
    MUIR, William Williamson
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish1418340001
    SMITH, Gail Margaret
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish335375130001
    WALKER, Douglas
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish337364970001
    MALONE, Gary Patrick
    Marywell Brae
    Kirriemuir
    DD8 4BJ Angus
    12
    United Kingdom
    Sekretär
    Marywell Brae
    Kirriemuir
    DD8 4BJ Angus
    12
    United Kingdom
    British128076840001
    ANDERSON, Katharine Ruth
    St. James Road
    DD8 2AQ Forfar
    1-3 St James Road
    Scotland
    Geschäftsführer
    St. James Road
    DD8 2AQ Forfar
    1-3 St James Road
    Scotland
    ScotlandBritish72355380001
    BAKER, Jack Rae Herron
    30 Duncan Avenue
    DD11 2DA Arbroath
    Angus
    Geschäftsführer
    30 Duncan Avenue
    DD11 2DA Arbroath
    Angus
    British92049110001
    BROWN, Colin Andrew Webster
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish195406560001
    CALLANDER, Anne Margaret
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish162941340001
    CHALMERS, Gordon Douglas Milligan
    16 Kinghorne Street
    DD11 2LZ Arbroath
    Angus
    Geschäftsführer
    16 Kinghorne Street
    DD11 2LZ Arbroath
    Angus
    British105102040001
    CUNNINGHAM, Bernard John
    26 Townhead Road
    DD11 1SY Arbroath
    Angus
    Geschäftsführer
    26 Townhead Road
    DD11 1SY Arbroath
    Angus
    British99830110001
    DALLAS, James
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    Geschäftsführer
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    ScotlandBritish168180850001
    DICKSON, June
    16 Garten St
    DD5 3HH Dundee
    Tayside
    Geschäftsführer
    16 Garten St
    DD5 3HH Dundee
    Tayside
    ScotlandBritish92049100001
    DUNCAN, Alexandra Anne, Dr
    St. James Road
    DD8 2AQ Forfar
    1-3 St James Road
    Scotland
    Geschäftsführer
    St. James Road
    DD8 2AQ Forfar
    1-3 St James Road
    Scotland
    ScotlandIrish121437680002
    DYE, Isobel Beattie
    33 Edradour Gardens
    DD11 5BW Arbroath
    Angus
    Geschäftsführer
    33 Edradour Gardens
    DD11 5BW Arbroath
    Angus
    British96254880001
    FINDLATER, Judith Ann
    3 Waterside View
    DD7 6EA Carnoustie
    Angus
    Geschäftsführer
    3 Waterside View
    DD7 6EA Carnoustie
    Angus
    ScotlandBritish114020690001
    FORSYTH, Elizabeth Montgomery
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    Geschäftsführer
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    ScotlandBritish86339650001
    GOODALL, Charles William Donald
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    Geschäftsführer
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    ScotlandBritish91964770001
    GUILD, Rhona Margaret
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish82593760001
    JOHNSTONE, Iain Bruce
    The Anchorage
    23 Auchmithie
    DD11 5SQ Arbroath
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    The Anchorage
    23 Auchmithie
    DD11 5SQ Arbroath
    Angus
    Scotland
    British89223520001
    LAIRD, Margaret Harper
    Dumbarrow Mill Cottage
    DD8 2ST Forfar
    Tayside
    Geschäftsführer
    Dumbarrow Mill Cottage
    DD8 2ST Forfar
    Tayside
    British92330080001
    LAWRIE, Gillian Rae
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    Geschäftsführer
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    ScotlandBritish40609840001
    LEE, Kenneth White
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish295694500001
    LESLIE-MELVILLE, Ruth
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish181728100002
    MCGREGOR, Elizabeth Jane
    119 Glenmoy Terrace
    DD8 1NU Forfar
    Angus
    Geschäftsführer
    119 Glenmoy Terrace
    DD8 1NU Forfar
    Angus
    British107035870001
    MORRISON, Donald George
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish165354780001
    NEILSON, Sharon Jean
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish295694490001
    PRENTICE, Neil Robert
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish159153100001
    ROBERTSON BROWN, Anne
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish123570290002
    SCOTT, Frances
    5 Park Cottages
    Hillside
    DD10 9HU Montrose
    Tayside
    Geschäftsführer
    5 Park Cottages
    Hillside
    DD10 9HU Montrose
    Tayside
    ScotlandBritish92330030001
    SCOTT, Jill
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    Geschäftsführer
    5-7 The Cross
    DD8 1BX Forfar
    Third Sector Centre
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish308870550001
    TAYLOR, Brian Stanley
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    Geschäftsführer
    32-34 Guthrie Port
    Arbroath
    DD11 1RN Angus
    ScotlandBritish169524260001
    THOMSON, Agnes
    18 Beacon Terrace
    Ferryden
    DD10 9RU Montrose
    Angus
    Geschäftsführer
    18 Beacon Terrace
    Ferryden
    DD10 9RU Montrose
    Angus
    ScotlandBritish98793980001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für VOLUNTARY ACTION ANGUS?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    28. Apr. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0