DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC254626 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DOCUMENT OUTSOURCING LIMITED | 25. Nov. 2003 | 25. Nov. 2003 |
| QUILLCO 151 LIMITED | 22. Aug. 2003 | 22. Aug. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 06. Aug. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 20. Aug. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 06. Aug. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Änderung der Details des Direktors für Chris Walsh am 05. Jan. 2026 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony John Strong als Geschäftsführer am 19. Dez. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Aug. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderungen an der schwebenden Belastung SC2546260005 | 17 Seiten | 466(Scot) | ||
Änderungen an der schwebenden Belastung SC2546260006 | 18 Seiten | 466(Scot) | ||
Eintragung der Belastung SC2546260006, erstellt am 29. Mai 2025 | 20 Seiten | MR01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2025 bis 31. Dez. 2024 | 1 Seiten | AA01 | ||
Ernennung von Mr Andrew David Herd als Direktor am 20. März 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Christian Alexander Paul Dickson als Direktor am 20. März 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Pawel Jernas als Geschäftsführer am 20. März 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Marcin Jernas als Geschäftsführer am 20. März 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Mitul Jay Rughani als Sekretär am 20. März 2025 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Chris Walsh als Direktor am 23. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Shane William Joseph Woods als Direktor am 23. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Nicholas Keegan als Direktor am 23. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Pawel Jernas als Direktor am 23. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Marcin Jernas als Direktor am 23. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Christopher Johnson als Geschäftsführer am 23. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gerrard Martin Crawley als Geschäftsführer am 23. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Samantha Jayne Ghysen als Sekretär am 23. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Eintragung der Belastung SC2546260005, erstellt am 23. Dez. 2024 | 16 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 18 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung SC2546260004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUGHANI, Mitul Jay | Sekretär | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | 334021890001 | |||||||
| DICKSON, Christian Alexander Paul | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | England | British | 208390720001 | |||||
| HERD, Andrew David | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | England | British | 129949980001 | |||||
| KEEGAN, Nicholas | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Ireland | Irish | 332065030001 | |||||
| SAVAGE, Hayden John | Geschäftsführer | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 255239970001 | |||||
| WALSH, Christopher James, Mr. | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Ireland | Irish | 332067340002 | |||||
| WOODS, Shane William Joseph | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Ireland | Irish | 332065170001 | |||||
| FRASER, William | Sekretär | Woodside Houston PA6 7DD Johnstone 19 Renfrewshire Scotland | British | 140871510001 | ||||||
| GHYSEN, Samantha Jayne | Sekretär | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road LE3 1UQ Leicester 133-137 Scudamore Road England | 266287460001 | |||||||
| HARTLEY, Ian | Sekretär | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | 174505510001 | |||||||
| KELLY, Paul Matthew | Sekretär | 13 Ladysneuk Road FK9 5NE Stirling Stirlingshire | British | 71750740001 | ||||||
| MCCALLUM, Lynne Margaret | Sekretär | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | 181178660001 | |||||||
| MCILQUHAM, Lorraine | Sekretär | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | 161713520001 | |||||||
| MCNULTY, Gary Edward | Sekretär | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | 164367170001 | |||||||
| SAUNDERS, Scott | Sekretär | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | British | 72070340003 | ||||||
| QUILL SERVE LIMITED | Sekretär | C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House EH1 2AA Rutland Square Edinburgh | 38236860004 | |||||||
| BELL, Edward | Geschäftsführer | 20 Newton Court SL4 2SN Old Windsor | British | 95487590001 | ||||||
| CRAWLEY, Gerrard Martin | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 194792350001 | |||||
| DE HAAN, Peter Charles | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Switzerland | British | 289241980001 | |||||
| FARMER, Richard | Geschäftsführer | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 250540630001 | |||||
| FRASER, William | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 82128590002 | |||||
| HARTLEY, Ian | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 36694500004 | |||||
| JERNAS, Marcin | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Poland | Polish | 332064830001 | |||||
| JERNAS, Pawel | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Ireland | Polish | 332064900001 | |||||
| JOHNSON, Simon Christopher | Geschäftsführer | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road LE3 1UQ Leicester 133-137 Scudamore Road England | England | British | 110558260001 | |||||
| MCCALLUM, Lynne Margaret | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 164840160001 | |||||
| MCCALLUM, Neil David | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 161346940001 | |||||
| MCCOACH, John | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 64932850003 | |||||
| MCKAY, John Smillie | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 134487100001 | |||||
| RITCHIE, William Martin | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 36556530001 | |||||
| RUTHERFORD, Colin Neil | Geschäftsführer | 33 Antonine Road G68 0FE Dullatur Lanarkshire | Scotland | British | 102769820001 | |||||
| SCOTT, Graeme John | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Document House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | 101636440003 | |||||
| STRONG, Anthony John | Geschäftsführer | c/o Opus Trust Communications Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | 251441190002 | |||||
| SWEENEY, Charles | Geschäftsführer | Document House 3 Phoenix Crescent ML4 3NJ Strathclyde Business Centre Bellshill | Scotland | British | 58158990002 | |||||
| QUILL FORM LIMITED (SC100346) | Geschäftsführer | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 91889980001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus Trust Marketing Limited | 17. Dez. 2019 | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für DOCUMENT OUTSOURCING GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 22. Aug. 2016 | 17. Dez. 2019 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0