GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED

GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC287766
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Juli 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Apr. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Juli 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung04. Aug. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Juli 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2024

    2 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Ms Gillian Jane Wright am 21. Jan. 2025

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Andrew Scott-Dempster am 15. Jan. 2025

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Lianne Margaret Lodge als Geschäftsführer am 21. Dez. 2024

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Nicola Jane Dundas am 30. Dez. 2024

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von John Michael Greene Blair als Geschäftsführer am 29. Feb. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2023

    2 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Alan Robert John Gilfillan am 25. Jan. 2024

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von David Christopher Smith als Geschäftsführer am 14. Aug. 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Alan Robert John Gilfillan als Direktor am 19. Juli 2023

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Duncan Gibson am 05. Juni 2023

    2 SeitenCH01

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Murray Ross Macrae zum Geschäftsführer

    3 SeitenRP04AP01

    Ernennung von Mr Murray Ross Macrae als Direktor am 14. März 2023

    2 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    31. Mai 2023Second Filing The information on the form AP01 has been replaced by a second filing on 31/05/2023

    Änderung der Details des Direktors für Mr Fraser Gordon Leslie am 17. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alan James White am 09. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Henry Cannon Smith am 09. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gregor Kenneth John Peebles am 07. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Fiona Jane Cameron am 09. März 2023

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Murray Duncan Soutar als Geschäftsführer am 22. Jan. 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2022

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Isobell Ann Reid als Geschäftsführer am 15. Apr. 2022

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILLESPIE MACANDREW DIRECTORS LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Sekretär
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    RegistrierungsnummerSC287765
    110641160001
    ADAMS, Eilidh Gillian
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish270107590001
    CAMERON, Fiona Jane
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish213291010002
    DUNDAS, Nicola Jane
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish165827140004
    GIBSON, Christopher Duncan
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    EnglandBritish163554900004
    GILFILLAN, Alan Robert John
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish311320910002
    HAMILTON, Colin Stuart
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish228398950001
    IRONS, Kenneth Wyness
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish129508470001
    LESLIE, Fraser Gordon
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish201604140003
    MACRAE, Murray Ross
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish288107600001
    MALLON, Agnes
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish197312510002
    MCARTHUR, John
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish41805350002
    MCCULLOCH, Derek Ashley James
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish394840002
    MCDOWELL, Amy Joy
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish213292280001
    NEWTON, Lois Elizabeth Anne
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish294905560001
    PEEBLES, Gregor Kenneth John
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish208061860002
    SCOTT-DEMPSTER, Robert Andrew
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish87233030002
    SMITH, Henry Cannon
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish162244000002
    STIRLING, John Boyd
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    United KingdomBritish86738730002
    WHITE, Alan James
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish197312610002
    WILLIAMS, Simon Jonathan Conon
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish270107630001
    WRIGHT, Gillian Jane
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    Geschäftsführer
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish256782950002
    GILLESPIE MACANDREW WS
    31 Melville Street
    EH3 7JQ Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Melville Street
    EH3 7JQ Edinburgh
    900028620001
    ANDERSON, Alistair Robert
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish156399360002
    BLAIR, John Michael Greene
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish170098870003
    CAIRNS, Gordon Douglas
    Rowan Cottage
    Hawthornden
    EH18 1EE Lasswade
    Geschäftsführer
    Rowan Cottage
    Hawthornden
    EH18 1EE Lasswade
    ScotlandBritish1152180001
    CLARK, Gerrard Antony David
    15 Comiston Drive
    EH10 5QR Edinburgh
    Geschäftsführer
    15 Comiston Drive
    EH10 5QR Edinburgh
    United KingdomBritish34336820003
    HAMILTON, Gordon David
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    United KingdomBritish96285790001
    HUNTER, Stewart Lindsay Wilson
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish65745580008
    INNES, Gordon
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    United KingdomBritish62207840003
    JAAP, Douglas William
    75 Waggon Road
    Brightons
    FK2 0EJ Falkirk
    Stirlingshire
    Geschäftsführer
    75 Waggon Road
    Brightons
    FK2 0EJ Falkirk
    Stirlingshire
    ScotlandBritish151129590001
    LESLIE, Simon Alexander
    10 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    10 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish394860002
    LODGE, Lianne Margaret
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8EJ Midlothian
    ScotlandBritish217076830002
    MACGREGOR, James Sim Fraser
    102 Liberton Drive
    EH16 6NR Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    102 Liberton Drive
    EH16 6NR Edinburgh
    Midlothian
    British86738710001
    MACKAY, Colin
    5 Goshen Farm Steading
    EH21 8JL Musselburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Goshen Farm Steading
    EH21 8JL Musselburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1166170006

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gillespie Macandrew Llp
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Liability Partnership
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageScots Law
    RegistrierungsortCompanies House, Edinburgh
    RegistrierungsnummerSo300743
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0