PARENTS INCLUSION NETWORK

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARENTS INCLUSION NETWORK
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer SC301669
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARENTS INCLUSION NETWORK?

    • Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich PARENTS INCLUSION NETWORK?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Midsteeple Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARENTS INCLUSION NETWORK?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2018
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2018
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARENTS INCLUSION NETWORK?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    The company (charity no. SC037461) converted into a scio on 15/0618. 19/01/2018
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Stephanie Robertson als Direktor am 19. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Hill Margerison als Geschäftsführer am 19. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Fiona Copeland als Direktor am 19. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Angela Kane als Geschäftsführer am 19. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Denise Dalziel als Geschäftsführer am 19. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Lisa Callendar Bone als Geschäftsführer am 19. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Fiona Murray als Geschäftsführer am 27. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Maria Hammond als Geschäftsführer am 03. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Debbie Perkins als Geschäftsführer am 03. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Margaret Cook als Geschäftsführer am 03. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Kay Chalmers als Geschäftsführer am 18. Apr. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Denise Dalziel als Direktor am 10. März 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Lisa Callendar Bone als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Fiona Murray als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Debbie Perkins als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Mary Mack als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew Margerison als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Kay Chalmers als Direktor am 09. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jane Stitt als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Joyce Scott als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anne Jane Murray als Geschäftsführer am 09. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von PARENTS INCLUSION NETWORK?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COPELAND, Fiona
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish244610890001
    GOURLAY, Marion Helen
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish134490910001
    MACK, Mary
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225451460001
    MAYBANK, Caroline
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish160590760001
    NIVEN, Amber
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    United KingdomBritish193364340001
    ROBERTSON, Stephanie
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish244727140001
    JACKSON, Ruth Isobel
    1 Beechfield Lane
    Johnstonebridge
    DG11 1EY Lockerbie
    Dumfriesshire
    Sekretär
    1 Beechfield Lane
    Johnstonebridge
    DG11 1EY Lockerbie
    Dumfriesshire
    British112544040001
    PALMER, Rodney Birch
    Highfield View
    Torthorwald
    DG1 3GA Dumfries
    7
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Highfield View
    Torthorwald
    DG1 3GA Dumfries
    7
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    British128596070002
    ALLWOOD, Irene Esplin
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    ScotlandBritish126669890001
    CALLENDAR BONE, Lisa
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225455810001
    CHALMERS, Kay
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225449600001
    COOK, Margaret
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish202911980001
    COOK, Margaret
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    ScotlandBritish168377420001
    CRAWFORD, Susan
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish172860690002
    CURRAN, Diana Claire
    Upper Craigenbay
    Clatteringshaws
    DG7 3SQ New Galloway
    Kirkcudbrightshire
    Geschäftsführer
    Upper Craigenbay
    Clatteringshaws
    DG7 3SQ New Galloway
    Kirkcudbrightshire
    ScotlandBritish112543990001
    DALZIEL, Denise
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish226567530001
    DUGAN, Shirley Jane
    19 Hillview Avenue
    Georgetown
    DG1 4DX Dumfries
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    19 Hillview Avenue
    Georgetown
    DG1 4DX Dumfries
    Dumfriesshire
    British112544030001
    DYKES, Laura
    Mansegate
    Dunscore
    DG2 0TD Dumfries
    Dunriach
    Geschäftsführer
    Mansegate
    Dunscore
    DG2 0TD Dumfries
    Dunriach
    British134668400001
    FERGUSON, Joanne
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    ScotlandBritish172856850001
    HAMMOND, Maria
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    United KingdomBritish193363670001
    HIDDLESTON, Janet
    Newmains
    Shawhead
    DG2 9SJ Dumfries
    Dumfriesshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Newmains
    Shawhead
    DG2 9SJ Dumfries
    Dumfriesshire
    Scotland
    British30867920001
    HUGHES, Amelia
    Dalton
    DG11 1JZ Lockerbie
    Upper Dormont Farm
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dalton
    DG11 1JZ Lockerbie
    Upper Dormont Farm
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193386650001
    KANE, Angela
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish202912450001
    KEVAN, Shiralee Keenan
    11 St Medans
    Monreith
    DG8 9LL Newton Stewart
    Dumfries & Galloway
    Geschäftsführer
    11 St Medans
    Monreith
    DG8 9LL Newton Stewart
    Dumfries & Galloway
    ScotlandBritish126669950001
    LAW, Jacqueline
    Glencar
    Terregles Road
    DG2 9RJ Dumfries
    Dumfries & Galloway
    Geschäftsführer
    Glencar
    Terregles Road
    DG2 9RJ Dumfries
    Dumfries & Galloway
    ScotlandBritish112544000001
    LOCKWOOD, Jennifer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Great BritainBritish184613640001
    MARGERISON, Andrew Hill
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225450520001
    MCALLISTER, Toni Elizabeth
    Janefield House
    Tongland Road
    DG6 4UR Kirkcudbright
    Dumfries & Galloway
    Geschäftsführer
    Janefield House
    Tongland Road
    DG6 4UR Kirkcudbright
    Dumfries & Galloway
    British112544020001
    MCLEAN, Helen Ruth
    Carsemill House
    Burnhead
    DG2 0RX Dumfries
    Dumfries & Galloway
    Geschäftsführer
    Carsemill House
    Burnhead
    DG2 0RX Dumfries
    Dumfries & Galloway
    United KingdomBritish227999750001
    MORE, Judith
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 - 26 Friars Vennel
    DG1 2RL Dumfries
    The Hub
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    ScotlandBritish160592260001
    MORRIS, Sarah
    5 Dalmacallan View
    DG3 4GZ Moniaive
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    5 Dalmacallan View
    DG3 4GZ Moniaive
    Dumfriesshire
    British117549910001
    MURRAY, Anne Jane
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish147132250001
    MURRAY, Fiona
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225452950001
    PERKINS, Debbie
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    Geschäftsführer
    Midsteeple
    DG1 2BH Dumfries
    1 Midsteeple
    Scotland
    ScotlandBritish225452370001
    PHILLIPS, Margaret Ann
    Carsphairn
    DG7 3TQ Dumfries & Galloway
    Milnholm
    Geschäftsführer
    Carsphairn
    DG7 3TQ Dumfries & Galloway
    Milnholm
    ScotlandBritish134490770001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PARENTS INCLUSION NETWORK?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    01. Mai 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0