OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC332742 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
- Erbringung von Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung (09100) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Wo befindet sich OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Johnston Carmichael Llp Bishop's Court 29 Albyn Place AB10 1YL Aberdeen |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VIEWFOLD LIMITED | 22. Okt. 2007 | 22. Okt. 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Bericht über die Schlussversammlung der freiwilligen Liquidation | 3 Seiten | 4.26(Scot) | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Graeme Paul Sheach am 10. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Graeme Paul Sheach am 10. Apr. 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor, Regent Centre Regent Road Aberdeen AB11 5NS zum Johnston Carmichael Llp Bishop's Court 29 Albyn Place Aberdeen AB10 1YL am 04. Okt. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Craig Harvie als Direktor am 01. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Evert Derk Engelbartus Maandag als Geschäftsführer am 01. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEACH, Graeme Paul | Sekretär | Regent Road AB11 5NS Aberdeen 4th Floor Regent Centre United Kingdom | British | 159593540001 | ||||||
| HARVIE, Craig | Geschäftsführer | Regent Centre Regent Road AB11 5NS Aberdeen 4th Floor Scotland | Scotland | British | 209076690001 | |||||
| SHEACH, Graeme Paul | Geschäftsführer | Regent Road AB11 5NS Aberdeen 4th Floor Regent Centre United Kingdom | Scotland | Scottish | 159586950002 | |||||
| MAXWELL, George Walter Mitchell | Sekretär | 10 Springdale Crescent Bieldside AB15 9FG Aberdeen Aberdeenshire | British | 126973590001 | ||||||
| SHORT, Dawn | Sekretär | AB30 1EA Nr Laurencekirk 7 Bent Cottages Kincardineshire | British | 132183660001 | ||||||
| SLATTERY, Vincent Alfred | Sekretär | Errol Bank Cowgate AB51 0EN Oldmeldrum Aberdeenshire | Irish | 176000950001 | ||||||
| WYNESS, Stuart Maxwell | Sekretär | Cults Avenue Cults AB15 9RS Aberdeen 22 Aberdeenshire | British | 164835240001 | ||||||
| P & W SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Investment House 6 Union Row AB21 7DQ Aberdeen | 900021250001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Sekretär | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Sekretär | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| BAARS, Johannes Petrus Nicolaas | Geschäftsführer | Dempsey Court Queens Lane North AB15 4DY Aberdeen 30 Scotland | Scotland | Dutch | 135607500002 | |||||
| DEANS, Rory Stuart | Geschäftsführer | Kenfield House 16 Kenfield Crescent AB15 7UQ Aberdeen | Scotland | British | 1059710004 | |||||
| GOOSEN, Joseph Louisa Marie | Geschäftsführer | Kouterstraat 271, B-9130 Kieldrecht Belgium | Belgium | Dutch | 130390680001 | |||||
| MAANDAG, Evert Derk Engelbartus | Geschäftsführer | Regent Centre Regent Road AB11 5NS Aberdeen 4th Floor United Kingdom | Scotland | Dutch | 166106910001 | |||||
| MAXWELL, George Walter Mitchell | Geschäftsführer | 10 Springdale Crescent Bieldside AB15 9FG Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 126973590001 | |||||
| PHILIP, Graham Martin | Geschäftsführer | 37 Mizen Way KT11 2RL Cobham Surrey | United Kingdom | British | 2585740004 | |||||
| SLATTERY, Vincent Alfred | Geschäftsführer | Errol Bank Cowgate AB51 0EN Oldmeldrum Aberdeenshire | Scotland | Irish | 176000950001 | |||||
| VAN DER LINDEN, Carlos Everardus Maria | Geschäftsführer | Amerstraat 48 4535 Cl Terneuzen Netherlands | Dutch | 125976280001 | ||||||
| WOOD, Graeme | Geschäftsführer | 3 Earnsheugh Place Findon AB12 3TL Aberdeen | Scotland | British | 73239520004 | |||||
| P & W DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Investment House 6 Union Row AB21 7DQ Aberdeen | 900021240001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroon Offshore Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Regent Centre Regent Road AB11 5NS Aberdeen 4th Floor Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Erstellt am 10. Feb. 2011 Geliefert am 11. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Ship means the vessel mv vos venturer with hull no. 676: rights title and interest to and under the insurances,requisition and earnings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 07. Okt. 2010 Geliefert am 20. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Rights title and interest insurances, requisition compentsation and earnings relating to ship hull no 675. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 16. Juni 2010 Geliefert am 06. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Second assigned property - ship with hull no. 674 vos enterprise. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 25. Feb. 2010 Geliefert am 05. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben Rights title and interest requisition compensation the earnings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of general assignment | Erstellt am 07. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent, of the company in and under the refund guarantees, the put and call option agreement, the master agreement, the put option agreement, the bareboat charterparty, the novation agreement and the collateral deposit and pledge and the building contract - see form 410 and paper apart for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of general assignment | Erstellt am 07. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent, of the company in and under the refund guarantees, the put and call option agreement, the master agreement, the put option agreement, the bareboat charterparty, the novation agreement and the collateral deposit and pledge and the building contract - see form 410 and paper apart for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of general assignment | Erstellt am 07. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent, of the company in and under the refund guarantees, the put and call option agreement, the master agreement, the put option agreement, the bareboat charterparty, the novation agreement and the collateral deposit and pledge and the building contract - see form 410 and paper apart for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of general assignment | Erstellt am 07. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent, of the company in and under the refund guarantees, the put and call option agreement, the master agreement, the put option agreement, the bareboat charterparty, the novation agreement and the collateral deposit and pledge and the building contract - see form 410 and paper apart for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OFFSHORE SUPPORT VESSELS VIII LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0