FIFE GINGERBREAD
Überblick
| Unternehmensname | FIFE GINGERBREAD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
| Unternehmensnummer | SC365015 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIFE GINGERBREAD?
- Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich FIFE GINGERBREAD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 9 Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Scotland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIFE GINGERBREAD?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FIFE GINGERBREAD?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Sept. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 17. Sept. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Sept. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIFE GINGERBREAD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Miss Charlotte an Liddell als Direktor am 06. Jan. 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Hunter Cant als Direktor am 07. Dez. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Andrew Proudfoot als Geschäftsführer am 04. Dez. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2025 | 40 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 12 Seiten | MA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jemma Forbes als Sekretär am 02. Juli 2025 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lynne Dunn als Geschäftsführer am 23. Juni 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jemma Forbes als Geschäftsführer am 02. Juli 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Sharon Nicole Connon am 24. Okt. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2024 | 42 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Moseley als Direktor am 28. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lisa Eleanor Bray als Geschäftsführer am 28. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023 | 43 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Francis Scott als Geschäftsführer am 30. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Heslop als Direktor am 27. Feb. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Gemma Pettie als Direktor am 07. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lisa Eleanor Bray als Direktor am 10. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Sharon Nicole Connon als Direktor am 22. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Coryn Barclay als Geschäftsführer am 22. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 44 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIFE GINGERBREAD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT, John Hunter | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 240795840001 | |||||
| CHRISTIE, Stewart Alexander | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 209118280001 | |||||
| HESLOP, Stephen | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 153863130003 | |||||
| LIDDELL, Charlotte An | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 344427850001 | |||||
| MCFADDEN, Sharon Nicole | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 302896760002 | |||||
| MOSELEY, Mark | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 323941130001 | |||||
| PETTIE, Gemma | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 306519720001 | |||||
| SAYER, Kevin Gordon | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 297037720001 | |||||
| CROOKS, Karen | Sekretär | Rimsdale Crescent KY7 6FZ Glenrothes 4 Fife | British | 140567570001 | ||||||
| FORBES, Jemma | Sekretär | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | 283911610001 | |||||||
| HARDIE, Jacqueline | Sekretär | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | 268130850001 | |||||||
| MOYES, Yvonne Elizabeth | Sekretär | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | 184941810002 | |||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900028780001 | |||||||
| AITKEN, Gwyneth Margaret | Geschäftsführer | Forth Street KY8 4PF Leven Greig Institute Fife Scotland | Scotland | British | 248193540002 | |||||
| ANDERSON, Calum | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 261808620001 | |||||
| BARCLAY, Coryn | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | United Kingdom | United Kingdom | 205001190002 | |||||
| BARRIE, Joyce Leggate | Geschäftsführer | Longbraes Gardens KY2 5YJ Kirkcaldy 30 Fife Scotland | United Kingdom | Uk | 194899030001 | |||||
| BLACKLEY, Ray | Geschäftsführer | Forth Street KY8 4PF Leven Greig Institute Fife Scotland | Scotland | Uk | 184942700001 | |||||
| BOLTON, Jonathan | Geschäftsführer | Wemyss Court KY7 4SX Glenrothes 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 140398900001 | |||||
| BOLTON, Jonathan | Geschäftsführer | Wemyss Court KY7 4SX Glenrothes 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 140398900001 | |||||
| BRAY, Lisa Eleanor | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 177009510001 | |||||
| CASSELLS, Elaine | Geschäftsführer | Fernbank Avenue Windygates KY8 5FA Leven 21 Fife Scotland | Scotland | Uk | 53877500002 | |||||
| CLARK, Ian | Geschäftsführer | Orchardfield Avenue EH12 7SX Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | 166061230001 | |||||
| CROOKS, Karen | Geschäftsführer | Rimsdale Crescent KY7 6FZ Glenrothes 4 Fife | Scotland | British | 140567570001 | |||||
| CUNNINGHAM, Catherine Elsie | Geschäftsführer | St. Marys Terrace East Wemyss KY1 4LG Kirkcaldy 10 Fife Scotland | United Kingdom | Uk | 96813820001 | |||||
| DRYBURGH, Susan Elizabeth | Geschäftsführer | Main Street Methilhill KY8 2DN Leven 51 Fife | Scotland | British | 140567590002 | |||||
| DUNCAN, Rose | Geschäftsführer | Freuchie Mill Freuchie KY15 7JL Cupar 8 Scotland | Scotland | British | 213397430001 | |||||
| DUNN, Lynne | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 288952670001 | |||||
| FORBES, Jemma | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 268131770001 | |||||
| FRIEL, Kerrie Marie | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 246473270001 | |||||
| GALLACHER, Mike | Geschäftsführer | Forth Street KY8 4PF Leven Greig Institute Fife Scotland | Scotland | Uk | 184941950001 | |||||
| GOLDIE, Elizabeth | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 270363950001 | |||||
| HUMBERT, Carol Ann | Geschäftsführer | David Street KY1 1XA Kirkcaldy 20 Fife Scotland | United Kingdom | British | 124314120001 | |||||
| MCGREGOR, Jacqueline | Geschäftsführer | Craig Mitchell House Flemington Road KY7 5QF Glenrothes Unit 9 Scotland | Scotland | British | 255626010001 | |||||
| MILLEN, Catherine Dianne, Dr | Geschäftsführer | Chancelot Grove EH5 3AA Edinburgh 11/4 Scotland | Scotland | United Kingdom | 177544740001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für FIFE GINGERBREAD?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 03. Sept. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0