FIFE GINGERBREAD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFIFE GINGERBREAD
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited'
    Unternehmensnummer SC365015
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FIFE GINGERBREAD?

    • Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich FIFE GINGERBREAD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 9 Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Scotland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIFE GINGERBREAD?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FIFE GINGERBREAD?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis03. Sept. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung17. Sept. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis03. Sept. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für FIFE GINGERBREAD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Miss Charlotte an Liddell als Direktor am 06. Jan. 2026

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr John Hunter Cant als Direktor am 07. Dez. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von George Andrew Proudfoot als Geschäftsführer am 04. Dez. 2025

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2025

    40 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    12 SeitenMA

    Beendigung der Bestellung von Jemma Forbes als Sekretär am 02. Juli 2025

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Lynne Dunn als Geschäftsführer am 23. Juni 2025

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jemma Forbes als Geschäftsführer am 02. Juli 2025

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Miss Sharon Nicole Connon am 24. Okt. 2024

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2024

    42 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mark Moseley als Direktor am 28. Mai 2024

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Lisa Eleanor Bray als Geschäftsführer am 28. Mai 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023

    43 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Michael Francis Scott als Geschäftsführer am 30. Mai 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Heslop als Direktor am 27. Feb. 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Gemma Pettie als Direktor am 07. März 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Lisa Eleanor Bray als Direktor am 10. Jan. 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Miss Sharon Nicole Connon als Direktor am 22. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Coryn Barclay als Geschäftsführer am 22. Nov. 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    44 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von FIFE GINGERBREAD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CANT, John Hunter
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish240795840001
    CHRISTIE, Stewart Alexander
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish209118280001
    HESLOP, Stephen
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish153863130003
    LIDDELL, Charlotte An
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish344427850001
    MCFADDEN, Sharon Nicole
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish302896760002
    MOSELEY, Mark
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish323941130001
    PETTIE, Gemma
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish306519720001
    SAYER, Kevin Gordon
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish297037720001
    CROOKS, Karen
    Rimsdale Crescent
    KY7 6FZ Glenrothes
    4
    Fife
    Sekretär
    Rimsdale Crescent
    KY7 6FZ Glenrothes
    4
    Fife
    British140567570001
    FORBES, Jemma
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Sekretär
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    283911610001
    HARDIE, Jacqueline
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Sekretär
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    268130850001
    MOYES, Yvonne Elizabeth
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Sekretär
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    184941810002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900028780001
    AITKEN, Gwyneth Margaret
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish248193540002
    ANDERSON, Calum
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish261808620001
    BARCLAY, Coryn
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    United KingdomUnited Kingdom205001190002
    BARRIE, Joyce Leggate
    Longbraes Gardens
    KY2 5YJ Kirkcaldy
    30
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Longbraes Gardens
    KY2 5YJ Kirkcaldy
    30
    Fife
    Scotland
    United KingdomUk194899030001
    BLACKLEY, Ray
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    ScotlandUk184942700001
    BOLTON, Jonathan
    Wemyss Court
    KY7 4SX Glenrothes
    3
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Wemyss Court
    KY7 4SX Glenrothes
    3
    Fife
    Scotland
    ScotlandScottish140398900001
    BOLTON, Jonathan
    Wemyss Court
    KY7 4SX Glenrothes
    3
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Wemyss Court
    KY7 4SX Glenrothes
    3
    Fife
    Scotland
    ScotlandScottish140398900001
    BRAY, Lisa Eleanor
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish177009510001
    CASSELLS, Elaine
    Fernbank Avenue
    Windygates
    KY8 5FA Leven
    21
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Fernbank Avenue
    Windygates
    KY8 5FA Leven
    21
    Fife
    Scotland
    ScotlandUk53877500002
    CLARK, Ian
    Orchardfield Avenue
    EH12 7SX Edinburgh
    16
    Scotland
    Geschäftsführer
    Orchardfield Avenue
    EH12 7SX Edinburgh
    16
    Scotland
    ScotlandBritish166061230001
    CROOKS, Karen
    Rimsdale Crescent
    KY7 6FZ Glenrothes
    4
    Fife
    Geschäftsführer
    Rimsdale Crescent
    KY7 6FZ Glenrothes
    4
    Fife
    ScotlandBritish140567570001
    CUNNINGHAM, Catherine Elsie
    St. Marys Terrace
    East Wemyss
    KY1 4LG Kirkcaldy
    10
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    St. Marys Terrace
    East Wemyss
    KY1 4LG Kirkcaldy
    10
    Fife
    Scotland
    United KingdomUk96813820001
    DRYBURGH, Susan Elizabeth
    Main Street
    Methilhill
    KY8 2DN Leven
    51
    Fife
    Geschäftsführer
    Main Street
    Methilhill
    KY8 2DN Leven
    51
    Fife
    ScotlandBritish140567590002
    DUNCAN, Rose
    Freuchie Mill
    Freuchie
    KY15 7JL Cupar
    8
    Scotland
    Geschäftsführer
    Freuchie Mill
    Freuchie
    KY15 7JL Cupar
    8
    Scotland
    ScotlandBritish213397430001
    DUNN, Lynne
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish288952670001
    FORBES, Jemma
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish268131770001
    FRIEL, Kerrie Marie
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish246473270001
    GALLACHER, Mike
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Forth Street
    KY8 4PF Leven
    Greig Institute
    Fife
    Scotland
    ScotlandUk184941950001
    GOLDIE, Elizabeth
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish270363950001
    HUMBERT, Carol Ann
    David Street
    KY1 1XA Kirkcaldy
    20
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    David Street
    KY1 1XA Kirkcaldy
    20
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritish124314120001
    MCGREGOR, Jacqueline
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    Geschäftsführer
    Craig Mitchell House
    Flemington Road
    KY7 5QF Glenrothes
    Unit 9
    Scotland
    ScotlandBritish255626010001
    MILLEN, Catherine Dianne, Dr
    Chancelot Grove
    EH5 3AA Edinburgh
    11/4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Chancelot Grove
    EH5 3AA Edinburgh
    11/4
    Scotland
    ScotlandUnited Kingdom177544740001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für FIFE GINGERBREAD?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    03. Sept. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0