ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | SC370513 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Station Seven 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Scotland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JOGGING BUDDIES | 23. Dez. 2009 | 23. Dez. 2009 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Dez. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 23. Dez. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Dez. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 34 Seiten | AA | ||
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 Seiten | RP01AP01 | ||
Ernennung von Mr Frank Boyle als Direktor am 28. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Notification of Susie Jane Paterson as a person with significant control on 30. Juni 2025 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Lindsay Maureen Moffat as a person with significant control on 30. Juni 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Lindsay Maureen Moffat als Geschäftsführer am 30. Juni 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 33 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Lindsay Maureen Moffat as a person with significant control on 27. Aug. 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Sarah-Jane Russell as a person with significant control on 27. Aug. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Sarah-Jane Russell als Geschäftsführer am 27. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Diane Eva Webb als Geschäftsführer am 30. Jan. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Kenneth Beattie Hopkins als Direktor am 21. Nov. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Ms Sheila Macdonald King als Direktor am 21. Nov. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Cessation of Lindsay Maureen Moffat as a person with significant control on 23. Okt. 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Sarah-Jane Russell as a person with significant control on 23. Okt. 2023 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2023 | 36 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mrs Susie Jane Paterson als Direktor am 26. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Graham Mcmillan als Geschäftsführer am 08. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 32 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Neil Mackinnon als Geschäftsführer am 14. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Laura Jean Mcburnie als Geschäftsführer am 19. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORLAND, Russell Taylor Mcallister | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 253080710001 | |||||||||
| BOYLE, Frank | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 342360310001 | |||||||||
| HOPKINS, Kenneth Beattie | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 316492730001 | |||||||||
| KING, Sheila Macdonald | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | Scottish | 316491160001 | |||||||||
| PATERSON, Susie Jane | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 308818320001 | |||||||||
| THOMPSON, Isabel Irvine | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | Scottish | 295046610001 | |||||||||
| WHALEN, Annette | Sekretär | Craigholme PA6 7DB Houston 3 Renfrewshire | British | 149903170001 | ||||||||||
| BRIAN REID LTD | Sekretär | Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh 5 Logie Mill |
| 147840780001 | ||||||||||
| BOHME, Karen Mary | Geschäftsführer | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire | United Kingdom | British | 184426420001 | |||||||||
| CHISHOLM, Alison Mary | Geschäftsführer | 8 Gordon Street G1 3PL Glasgow Tontine House | Scotland | British | 59042480001 | |||||||||
| CLARK, Catherine Forrest | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 2a Scotland | Scotland | Scottish | 261930440001 | |||||||||
| COULL, Wendy | Geschäftsführer | Saltire Crescent ML9 2LG Larkhall 30 | Scotland | British | 149903100001 | |||||||||
| COYLE, Sharon | Geschäftsführer | Barwood Drive PA8 6AQ Erskine 9 Scotland | Scotland | British | 246772770001 | |||||||||
| DAVIDSON, Margaret Ann | Geschäftsführer | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire | Scotland | British | 149902620002 | |||||||||
| KING, Norman | Geschäftsführer | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 United Kingdom | Scotland | British | 184352080001 | |||||||||
| MABBOTT, Stephen George | Geschäftsführer | Mitchell Lane G1 3NU Glasgow 14 | Scotland | British | 133953120001 | |||||||||
| MACKINNON, Neil | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DY Johnstone 7 Quarry Street Scotland | Scotland | British | 258929270001 | |||||||||
| MARTIN, Margaret Ann | Geschäftsführer | Stamperland Gardens Clarkston G76 8NR Glasgow 80 | Scotland | British | 149902930001 | |||||||||
| MCBURNIE, Laura Jean | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 295912770001 | |||||||||
| MCDONALD, Janis White | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 16 Scotland | Scotland | British | 209848600001 | |||||||||
| MCDONALD, Susan | Geschäftsführer | 50 Darvel Crescent Ralston PA1 3EQ Paisley East Lodge Renfrewshire | Scotland | British | 114668140001 | |||||||||
| MCKEOWN, John | Geschäftsführer | Edmiston Drive Linwood PA3 3TD Paisley 30 Scotland | Scotland | British | 230921380001 | |||||||||
| MCLEAN, Susan Perry | Geschäftsführer | 1 Friarshall Gate Paisley PA2 6LD Paisley 2/2 Burrell Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | 116534380001 | |||||||||
| MCMILLAN, Graham | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 272457680001 | |||||||||
| MCNICOL, Rae | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 2a Scotland | Scotland | British | 256464300001 | |||||||||
| MOFFAT, Lindsay Maureen | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | Scottish | 261930210001 | |||||||||
| MOIR, Helen | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 16 Scotland | Scotland | Scottish | 149902810001 | |||||||||
| MOIR, Helen | Geschäftsführer | Binend Road Pollok G53 5JB Glasgow 15 | Scotland | Scottish | 149902810001 | |||||||||
| MURPHY, Alison Mary | Geschäftsführer | St. Annes Wynd PA8 7DT Erskine 8 Scotland | United Kingdom | British | 181278500001 | |||||||||
| ROBERTSON, Roisin | Geschäftsführer | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 United Kingdom | Scotland | British | 184352090001 | |||||||||
| RUSSELL, Sarah-Jane | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 277241250001 | |||||||||
| STEWART, Suzanne Russell | Geschäftsführer | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire Scotland | Scotland | British | 184352100001 | |||||||||
| WEBB, Diane Eva | Geschäftsführer | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Scotland | British | 295932430001 | |||||||||
| WHALEN, Annette | Geschäftsführer | Craigholme PA6 7DB Houston 3 Renfrewshire | Scotland | British | 149903000001 | |||||||||
| WOJCIECHOWSKA, Olga | Geschäftsführer | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 16 Scotland | Scotland | Polish | 277244920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ACTIVE COMMUNITIES (SCOTLAND) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Ms Susie Jane Paterson | 30. Juni 2025 | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Miss Lindsay Maureen Moffat | 27. Aug. 2024 | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Ja |
Nationalität: Scottish Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Sarah-Jane Russell | 23. Okt. 2023 | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Lindsay Maureen Moffat | 21. März 2022 | 7 Quarry Street PA5 8DY Johnstone Station Seven Scotland | Ja |
Nationalität: Scottish Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Ms Janis White Mcdonald | 19. Nov. 2021 | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 16 Scotland | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Miss Helen Moir | 09. Sept. 2019 | Quarry Street PA5 8DZ Johnstone 16 Scotland | Ja |
Nationalität: Scottish Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Miss Fiona Winton | 09. Sept. 2019 | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire | Ja |
Nationalität: Scottish Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Susan Perry Mclean | 29. Juni 2018 | Friarshall Gate PA2 6LD Paisley 2/2 Burrell Scotland | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Susan Mclean | 19. Juni 2018 | 1 Friarshall Gate PA2 6LD Paisley 1/1 Scotland | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Karen Bohme | 09. Dez. 2016 | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Norman King | 09. Dez. 2016 | 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley Room 11 Renfrewshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Margaret Ann Davidson | 09. Dez. 2016 | Room 11 41 Blackstoun Road PA3 1LU Paisley 41 Renfrewshire Scotland | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0