KINGDOM INITIATIVES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KINGDOM INITIATIVES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC383963 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Saltire Centre Pentland Court KY6 2DA Glenrothes |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Aug. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Aug. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Aug. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Mark Richard Bramwell als Geschäftsführer am 23. Apr. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Finlay Ross als Geschäftsführer am 02. Feb. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 33 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Mark Richard Bramwell als Direktor am 17. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Dr Gillian Chin als Direktor am 17. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Lewis Mckenzie als Direktor am 17. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Alexander Easton als Geschäftsführer am 05. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Derek Helmore als Geschäftsführer am 01. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Michael Philip Fitzgerald als Direktor am 09. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 34 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Stuart James Wilson als Geschäftsführer am 20. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. März 2023 | 32 Seiten | AAMD | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2023 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Thomas Anderson Barclay als Direktor am 20. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von William Banks als Geschäftsführer am 21. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Garry Dickson als Geschäftsführer am 29. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 32 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Lawrie West als Direktor am 19. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mrs Andrea Saunders als Direktor am 19. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAY, Thomas Anderson | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | Scottish | 217831170001 | |||||
| CHIN, Gillian, Dr | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | Malaysian | 332649990001 | |||||
| FITZGERALD, Michael Philip | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | Scottish | 256239030001 | |||||
| MCKENZIE, Lewis | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | Scottish | 332649800001 | |||||
| MORDI, Loretta | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | Nigerian | 271184280001 | |||||
| SAUNDERS, Andrea | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 282429040001 | |||||
| WEST, Lawrie | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 163239020001 | |||||
| BANKS, William | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | United Kingdom | British | 87332760001 | |||||
| BOYLE, Elspeth | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 251092590001 | |||||
| BRAMWELL, Mark Richard | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 332830690001 | |||||
| CONNELLY, Iain Miller | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 206621400001 | |||||
| DICKSON, Garry | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 237803160001 | |||||
| EASTON, Mark Alexander | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 250614310001 | |||||
| FOTHERINGHAM, Eleanor | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 153547190001 | |||||
| GRAY, John Douglas | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 850002 | |||||
| HELMORE, Derek | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 166008540001 | |||||
| LEES, Freya Ann | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 203098790001 | |||||
| LITTLE, David Alexander | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre Fife Scotland | Scotland | British | 1355610001 | |||||
| MCGUCKIN, Alan Thirsk | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 95117160001 | |||||
| ROSS, Finlay | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 282428650001 | |||||
| TOWNS, Eric Ernest | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 186108810001 | |||||
| WILSON, Stuart James | Geschäftsführer | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre | Scotland | British | 128999200001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KINGDOM INITIATIVES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingdom Housing Association Limited | 01. Juni 2016 | Pentland Court KY6 2DA Glenrothes Saltire Centre Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0