COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)
Überblick
| Unternehmensname | COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE) |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Nicht registrierte Gesellschaft |
| Unternehmensnummer | ZC000184 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
- Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Landverkehr n.n.a. (52219) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hotspur House Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
|---|---|
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Ernennung von Benjamin George Richardson als Direktor am 22. Apr. 2024 | 3 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Malcolm Seedwell als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2019 bis 31. Jan. 2019 | 3 Seiten | AA01 | ||
Notification of Whit Three Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Notification of Whit Two Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Notification of Whit One Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Ernennung von Mr James Crothers Habgood Percy als Direktor am 21. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Andrew George Percy als Direktor am 21. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Philip Malcolm Seedwell als Direktor am 21. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Rutherford Weir als Geschäftsführer am 21. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert Henry Charles Plumb als Geschäftsführer am 21. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael John Beckley als Geschäftsführer am 21. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charles Thomas Micklem als Geschäftsführer am 21. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Whitchurch Bridge Two Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Whitchurch Bridge Three Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Whitchurch Bridge One Limited as a person with significant control on 21. Feb. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Rutherford Weir als Sekretär am 21. Feb. 2019 | 2 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Toll House High Street Whitchurch on Thames Reading Berkshire RG8 7DF zum Hotspur House Prospect Place Hythe Southampton Hampshire SO45 6AU am 12. März 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Notification of Whitchurch Bridge Three Limited as a person with significant control on 20. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Notification of Whitchurch Bridge One Limited as a person with significant control on 20. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Notification of Whitchurch Bridge Two Limited as a person with significant control on 20. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||
Withdrawal of a person with significant control statement on 06. März 2019 | 3 Seiten | PSC09 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCY, Andrew George | Geschäftsführer | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | 15943900001 | |||||
| PERCY, James Crothers Habgood | Geschäftsführer | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | 99560570005 | |||||
| RICHARDSON, Benjamin George | Geschäftsführer | Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House England | England | British | 322848150001 | |||||
| BECKLEY, Eric James Sexstone | Sekretär | 3 Breckland Green North Pickenham PE37 8LG Swaffham Norfolk | British | 42191280001 | ||||||
| ELKINS, John Louis | Sekretär | 20 Glynswood OX39 4JE Chinnor Oxfordshire | British | 50628090003 | ||||||
| WEIR, Geoffrey Rutherford | Sekretär | High Street Whitchurch-On-Thames RG8 7DB Reading Wells House Berkshire | British | 50628040001 | ||||||
| BECKLEY, Eric James Sexstone | Geschäftsführer | 3 Breckland Green North Pickenham PE37 8LG Swaffham Norfolk | British | 42191280001 | ||||||
| BECKLEY, Michael John | Geschäftsführer | The Homestead Little Marsh OX27 0AP Marsh Gibbon Buckinghamshire | England | British | 87272380001 | |||||
| CUMBER, William John | Geschäftsführer | 62 High Street Theale RG7 5AN Reading | British | 42191260001 | ||||||
| ELKINS, John Louis | Geschäftsführer | 20 Glynswood OX39 4JE Chinnor Oxfordshire | British | 50628090003 | ||||||
| FITZGERALD, Patrick Ian | Geschäftsführer | Fairbourne 28 The Rise TN13 1RQ Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 34954130003 | |||||
| FREEMAN, Margaret Jill | Geschäftsführer | Latchford Farm Great Haseley OX44 7BG Oxford | British | 61720850001 | ||||||
| FRYER, John Denny | Geschäftsführer | Sandacre Woodside Frilford Heath OX13 5QG Abingdon Oxfordshire | British | 46064820001 | ||||||
| MICKLEM, Charles Thomas | Geschäftsführer | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | United Kingdom | British | 13267110001 | |||||
| MICKLEM, Charles Thomas | Geschäftsführer | The Pheasantries Bellingdon HP5 2XW Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13267110001 | |||||
| MICKLEM, Eleanor Ruth | Geschäftsführer | 24 Frognal Court Finchley Road NW3 5HG London | British | 46064830001 | ||||||
| MICKLEM, Nathaniel | Geschäftsführer | Sheepstead House Abingdon Oxfordshire | British | 42191270001 | ||||||
| PLUMB, Robert Henry Charles | Geschäftsführer | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | England | British | 20686100001 | |||||
| SEEDWELL, Philip Malcolm | Geschäftsführer | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire | United Kingdom | British | 253682460001 | |||||
| VALE, William Richard Frederick | Geschäftsführer | The White House Stoford Water EX15 2HG Cullompton Devon | British | 46064810001 | ||||||
| WEIR, Geoffrey Rutherford | Geschäftsführer | Wells House Eastfield Lane Whitchurch On Thames RG8 7EJ Reading Berkshire | United Kingdom | British | 50628040001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whit Two Limited | 21. Feb. 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Whit One Limited | 21. Feb. 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Whit Three Limited | 21. Feb. 2019 | Prospect Place Hythe SO45 6AU Southampton Hotspur House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Whitchurch Bridge Two Limited | 20. Feb. 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Whitchurch Bridge Three Limited | 20. Feb. 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Whitchurch Bridge One Limited | 20. Feb. 2019 | High Street Whitchurch On Thames RG8 7DB Reading Wells House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für COMPANY OF PROPRIETORS OF WHITCHURCH BRIDGE (THE)?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 31. Dez. 2016 | 20. Feb. 2019 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0