Peter Alan COWGILL - Seite 5
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Peter |
Zweites Vornamen | Alan |
Nachname | COWGILL |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 12 |
Inaktiv | 32 |
Zurückgetreten | 161 |
Gesamt | 205 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANNY STATE LIMITED | 03. Aug. 2010 | 28. Sept. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
DUFFER OF ST GEORGE LIMITED | 24. Nov. 2009 | 28. Sept. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
NICHOLAS DEAKINS LTD. | 11. Apr. 2008 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
PINK SODA LIMITED | 07. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
VARSITY KIT LIMITED | 07. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
FOCUS BRANDS LIMITED | 03. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
FOCUS EQUIPMENT LIMITED | 03. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
FOCUS GROUP HOLDINGS LIMITED | 03. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
HELA BRANDS LIMITED | 03. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
FOCUS SPORTS AND LEISURE INTERNATIONAL LIMITED | 03. Dez. 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
THE JOHN DAVID GROUP LIMITED | 05. Juni 2007 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
SONNETI FASHIONS LIMITED | 20. März 2005 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
ALLSPORTS.CO.UK LIMITED | 20. März 2005 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
ATHLEISURE LIMITED | 20. März 2005 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
FIRST SPORT LIMITED | 22. Dez. 2004 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
R. D. SCOTT LIMITED | 15. Dez. 2004 | 28. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
APPLIED NUTRITION PLC | 07. Mai 2021 | 23. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollins Brook Way BL9 8RR Bury C/O Jd Sports Fashion Plc England | England | British |
MARSHALL ARTIST HOLDINGS LTD | 29. Apr. 2021 | 23. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alderley Road SK9 1PT Wilmslow 97 England | England | British |
BRAND STABLE LTD | 21. Apr. 2021 | 23. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 65 Jeddo Road W12 9ED London Atlantic House | England | British |
JD SPORTS FASHION PLC | 16. März 2004 | 08. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hollinsbrook Way Pilsworth BL9 8RR Bury Edinburgh House Lancashire United Kingdom | England | British |
MALLET. FOOTWEAR LTD | 28. Feb. 2018 | 25. Mai 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Pilsworth BL9 8RR Bury Hollinsbrook Way Lancashire England | England | British |
COWGILL HOLLOWAY LLP | 03. Jan. 2006 | 20. Mai 2022 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | Regency House 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Lancashire | England | ||
CHESHIRE POLYTHENE FILM COMPANY LIMITED | 31. Mai 1993 | 08. Juli 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House | England | British |
HIGHBANK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 18. Nov. 2002 | 14. Juni 2021 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | United Kingdom | British |
UNITED CARPETS GROUP LIMITED | 08. Dez. 2004 | 29. Jan. 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | United Kingdom | British |
BETTERBATHROOMS (UK) LIMITED | 24. Jan. 2017 | 27. Nov. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Greenfold Way WN7 3XH Leigh Horizon Park Lancashire | England | British |
ATRIA HOLDINGS LIMITED | 12. Apr. 2011 | 30. Juni 2017 | Aktiv | None | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British |
MCLEAN ARCHITECTS LIMITED | 30. Juni 1997 | 09. Dez. 2016 | Aktiv | Director | Sekretär | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | British | |
BANK FASHION LIMITED | 07. Dez. 2007 | 25. Nov. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 45-49 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British |
MBL GROUP PLC | 26. Juni 2006 | 17. Juni 2014 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | United Kingdom | British |
BERKELEY SQUARE CAPITAL LIMITED | 05. Juni 2002 | 24. Apr. 2013 | Aktiv | Finance Director | Sekretär | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | British | |
BERKELEY SQUARE CAPITAL LIMITED | 05. Juni 2002 | 31. März 2013 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 14 The Hamlet High Bank Lane BL6 4QT Bolton Lancashire | United Kingdom | British |
LYONS 3 LIMITED | 23. Juni 2010 | 15. Okt. 2012 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Plantation Road Burscough Industrial Estate L40 8JT Ormskirk Lancashire | United Kingdom | British |
CANTERBURY EUROPEAN FASHIONWEAR LIMITED | 27. Juli 2010 | 13. Sept. 2012 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Manchester Square W1U 3PH London 8 | United Kingdom | British |
CANTERBURY COTTON OXFORD LIMITED | 30. Aug. 2009 | 13. Sept. 2012 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 45-49 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0