• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Robert Anthony BAILEY - Seite 3

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameRobert
    Zweites VornamenAnthony
    NachnameBAILEY
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv6
    Inaktiv24
    Zurückgetreten70
    Gesamt100

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    COLORAMA PHOTODISPLAY HOLDINGS LIMITED04. Feb. 200201. Okt. 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    MIDAS ENGINEERING SERVICES LIMITED05. Juli 200224. Juli 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    DRAYTON BEAUMONT KILNS LIMITED04. Juli 200210. Juli 2002AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    1602 GROUP LIMITED05. Feb. 200205. Juli 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    ROLTECH ENGINEERING LIMITED04. Feb. 200208. Mai 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    P & F CONGLETON LIMITED18. Feb. 200230. Apr. 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    GALLEY BRIDGE (HOLDINGS) LIMITED04. Feb. 200218. Apr. 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    C&F GROUP HOLDINGS LIMITED18. Feb. 200208. Apr. 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    VARLEY HYDRAULICS LIMITED18. Feb. 200213. März 2002AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    MAMAC SYSTEMS (UK) LIMITED22. Mai 199719. Jan. 2001AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    LA PERLA (CHARLOTTE ST) LIMITED15. Juni 199929. Nov. 2000AufgelöstSolicitorSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    GEMSTONE FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED18. Feb. 200024. Aug. 2000AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    FITCH LEARNING LIMITED18. Feb. 200015. Aug. 2000AktivSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    WYRE FOREST LAND COMPANY LIMITED18. Feb. 200002. Aug. 2000AktivSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    J S W FINANCIAL GUIDANCE LIMITED19. Apr. 199906. Juni 2000AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HOLIDAY TRAVELWATCH LIMITED18. Feb. 200005. Mai 2000AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    MARTYN PRICE PROPERTIES LIMITED18. Feb. 200007. Apr. 2000AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    LA PERLA (CHARLOTTE ST) LIMITED19. Apr. 199915. Juni 1999AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    NOWELL & RICHARDS INSURANCE SERVICES LIMITED19. Apr. 199922. Apr. 1999AktivSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    P & A ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED19. Apr. 199922. Apr. 1999AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    GSA TECHSOURCE LIMITED23. Dez. 199704. Juni 1998AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    ROSKEL HOLDINGS LIMITED31. Okt. 199705. Nov. 1997AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    SPECIALIST COMPUTERS INTERNATIONAL LIMITED14. Aug. 199719. Aug. 1997AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    SCC OVERSEAS HOLDINGS LIMITED10. Juni 199725. Juli 1997AktivSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    SCH GROUP SERVICES LIMITED22. Juli 199725. Juli 1997AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    SPECIALIST COMPUTERS CORPORATION (UK) LIMITED10. Juni 199725. Juli 1997AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    THE KINGS HOTEL (CHIPPING CAMPDEN) LIMITED10. Juni 199725. Juli 1997AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    SCC FINANCIAL SERVICES LIMITED09. Juni 199725. Juli 1997AufgelöstSekretär
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    British
    SPECIALIST COMPUTER PROPERTIES LIMITED19. Feb. 199703. März 1997AufgelöstSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish
    PULLMAN COURT PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED25. Nov. 199618. Dez. 1996AktivSolicitorGeschäftsführer
    5 The Thistles Thistlebury Avenue
    ST5 2HR Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0