Teresa Carol THOMSON
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Teresa |
Zweites Vornamen | Carol |
Nachname | THOMSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 6 |
Inaktiv | 14 |
Zurückgetreten | 7 |
Gesamt | 27 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERYCO LIMITED | 01. Apr. 2025 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | The Haugh Blairgowrie PH10 7ER Perthshire | Scotland | British | |
A. PROCTOR INSULATION LIMITED | 01. Apr. 2025 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | The Haugh Blairgowrie PH10 7ES Perthshire | Scotland | British | |
A. PROCTOR CONSTRUCTION LIMITED | 01. Apr. 2025 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | The Haugh Rattray PH10 7ER Blairgowrie Perthshire | Scotland | British | |
A.R.M. BUILDINGS LIMITED | 01. Apr. 2025 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Unit 3 Rydal Estate Colton Road WS15 3HF Rugeley Staffordshire | Scotland | British | |
A. PROCTOR GROUP LIMITED | 01. Apr. 2025 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | The Haugh Blairgowrie PH10 7ER Perthshire | Scotland | British | |
GALLOWAY GROUP LTD. | 06. Jan. 2014 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 5 George Square G2 1DY Glasgow G1 | Scotland | British | |
GALLOWAY (HOLDINGS) LIMITED | 06. Jan. 2014 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place | Scotland | British | |
DUCTMATE (EUROPE) LIMITED | 06. Jan. 2014 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 5 George Square G2 1DY Glasgow G1 | Scotland | British | |
KENRICK & JEFFERSON LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
REGIS ENVELOPES LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
K & J ENVELOPES LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
THE GRAB BAG COMPANY LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
EXPRESS ENVELOPES LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
FETTYKIL LIMITED | 11. Mai 2007 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | British | ||
THE GRAB BAG COMPANY LIMITED | 02. Okt. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
K & J ENVELOPES LIMITED | 30. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
REGIS ENVELOPES LIMITED | 30. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
KENRICK & JEFFERSON LIMITED | 30. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
EXPRESS ENVELOPES LIMITED | 30. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
FETTYKIL LIMITED | 30. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Munro Court KY7 5GD Glenrothes 5 Fife | Scotland | British | |
SPACE SOLUTIONS (SCOTLAND) LIMITED | 07. Mai 2019 | 19. Dez. 2024 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Bishop House 50 Carden Place AB10 1UP Aberdeen | Scotland | British |
SMITH ANDERSON PACKAGING LIMITED | 26. Mai 2011 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British |
SMITH ANDERSON GROUP LIMITED | 01. Juli 2009 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British |
SMITH ANDERSON GROUP LIMITED | 24. Mai 2007 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Head Of Finance & It | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | |
SMITH ANDERSON PACKAGING LIMITED | 11. Mai 2007 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Group Financial Controller | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | |
SMITH ANDERSON ENVELOPES LIMITED | 11. Mai 2007 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Accountant | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | |
SMITH ANDERSON ENVELOPES LIMITED | 08. Juni 2006 | 29. Nov. 2013 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0