SMITH ANDERSON GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SMITH ANDERSON GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | SC207391 |
| Gerichtsbarkeit | Schottland |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
- Herstellung von Wellpapier und Wellpappe, Säcken und Beuteln (17211) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rosslyn Commerce Park Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Fife |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PACIFIC SHELF 957 LIMITED | 23. Mai 2000 | 23. Mai 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Feb. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 07. März 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Feb. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr Michael Kori als Sekretär am 07. Mai 2025 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Eric Verden-Anderson als Sekretär am 07. Mai 2025 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2024 | 36 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2025 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2024 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Kori als Direktor am 24. Aug. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 25 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Keith Eric Verden-Anderson als Sekretär am 03. März 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Simon Marriott als Geschäftsführer am 03. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Simon Marriott als Sekretär am 03. März 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 39 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2023 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Eric David Herdman Verden-Anderson als Direktor am 01. Dez. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Longstaffe als Geschäftsführer am 29. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2020 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Scott Edmund Partridge als Direktor am 28. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORI, Michael | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | 335494950001 | |||||||
| COLLERTON, Catriona Louise | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | England | British | 255134020001 | |||||
| KORI, Michael | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | Scotland | British | 312993020001 | |||||
| PARTRIDGE, Fiona Mary | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | 85313330003 | |||||
| PARTRIDGE, Scott Edmund | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | England | British | 255134370001 | |||||
| ROBERTSON, David Stewart | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | 39153760002 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, Eric David Herdman | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | Scotland | British | 1104630003 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, James Eric | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | 134186900001 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, Keith Eric | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | United Kingdom | British | 87730810001 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, William Graeme | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | United Kingdom | British | 72193130002 | |||||
| WOOD, David Wiliam | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | United States | British | 190771410002 | |||||
| MARRIOTT, David Simon | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | 242206710001 | |||||||
| ROBERTSON, David Stewart | Sekretär | 1 Lauder Road The Grange EH9 2EW Edinburgh | British | 39153760002 | ||||||
| THOMSON, Teresa Carol | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | British | 111029950001 | ||||||
| VERDEN-ANDERSON, Keith Eric | Sekretär | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | 309010110001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| COLLERTON, Carol-Ann Margaret | Geschäftsführer | Queen Anne's House Berry Hill SL6 0EP Taplow Bucks | British | 87111790001 | ||||||
| CRAIG, Frederick John Robert | Geschäftsführer | Well Brae Falkland KY15 7AY Cupar Fife | Scotland | British | 133316040001 | |||||
| DICKSON, Michael Ian Ross | Geschäftsführer | Cadgers Way Grange Earlsferry, Elie KY9 1AN Leven Fife | Scotland | British | 43607410002 | |||||
| HENRY, Brian | Geschäftsführer | Fettykil House Leslie KY6 3AR Glenrothes Fife | British | 31612780002 | ||||||
| HEPBURN, Gavin Andrew Harley | Geschäftsführer | 22 Mansionhouse Road EH9 2JD Edinburgh Midlothian | British | 211700001 | ||||||
| HOWLEY, David Anthony Andrew | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | United Kingdom | Irish | 139311220001 | |||||
| HUTT, Stephen Mark | Geschäftsführer | 11 Auld Mart Wynd Milnathort KY13 9FT Perth & Kinross Fife | British | 110569210001 | ||||||
| LONGSTAFFE, Michael James | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | 65557780006 | |||||
| MARRIOTT, David Simon | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife | United Kingdom | British | 242733140001 | |||||
| MURRAY, Edward Davidson | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | United Kingdom | British | 504780001 | |||||
| PARTRIDGE, Fiona Mary | Geschäftsführer | 7 Ardmore Avenue GU2 9NJ Guildford Surrey | United Kingdom | British | 85313330001 | |||||
| ROBERTSON, David Stewart | Geschäftsführer | 1 Lauder Road The Grange EH9 2EW Edinburgh | Scotland | British | 39153760002 | |||||
| THOMSON, Teresa Carol | Geschäftsführer | Mitchelston Industrial Estate KY1 3NA Kirkcaldy Rosslyn Commerce Park Fife Scotland | Scotland | British | 111029950001 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, Eric David Herdman | Geschäftsführer | Inchrye Lindores KY14 6JD Cupar Fife | Scotland | British | 1104630003 | |||||
| VERDEN-ANDERSON, James Eric | Geschäftsführer | 5 Oxford Terrace EH4 1PX Edinburgh Lothians | British | 92740220001 | ||||||
| VERDEN-ANDERSON, Keith Eric | Geschäftsführer | 16 Buckingham Terrace EH4 3AD Edinburgh | United Kingdom | British | 87730810001 | |||||
| WOOD, David William | Geschäftsführer | 14555 Adair Manor Court Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | British | 84548110001 | ||||||
| WOOD, David William | Geschäftsführer | 14555 Adair Manor Court Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | British | 84548110001 | ||||||
| WOOD, Evelyn Cameron | Geschäftsführer | Burntwood RH5 4BL Dorking Surrey | British | 420390001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für SMITH ANDERSON GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 24. Feb. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0