• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • James John JORDAN - Seite 11

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameJames
    Zweites VornamenJohn
    NachnameJORDAN
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv3
    Inaktiv48
    Zurückgetreten395
    Gesamt446

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    GEORGE WIMPEY CITY LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA HOLDINGS LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA YORKSHIRE LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY NORTH WEST LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    HASSALL HOMES (WESSEX) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    HASSALL HOMES (WESSEX) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    MCA SOUTH WEST LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY NORTH MIDLANDS LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY BRISTOL LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    LAING LAND LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY WEST LONDON LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY EAST LONDON LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AktivSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    CANBERRA INVESTMENT CO. LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    SHOWPINE LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    CANBERRA INVESTMENT CO. LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    VALENTINE PARK LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA (ALSAGER) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    UK HOME FINANCE LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    VALENTINE PARK LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA (KENDAL) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA (ALSAGER) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    ROCKHOLD LAND LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    SHOWPINE LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    COMPINE DEVELOPMENTS (MUNDFORD) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    MCA (KENDAL) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    COMPINE DEVELOPMENTS (MUNDFORD) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    ASHFIELD INVESTMENTS LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    IVA ESTATES LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    ST. ANNE'S VILLAGE LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    CORNEY REACH LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstCompany SecretaryGeschäftsführer
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    IVA (MIDLANDS) LIMITED31. Dez. 200706. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0