• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Michael Anthony ZIFF - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameMichael
    Zweites VornamenAnthony
    NachnameZIFF
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv5
    Inaktiv30
    Zurückgetreten18
    Gesamt53

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    JERUSALEM FOUNDATION TRUSTEES LIMITED09. Nov. 201001. Nov. 2017AktivDirectorGeschäftsführer
    880 Harrogate Road
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    England
    EnglandBritish
    MACCABI GB05. Dez. 200507. Sept. 2017AktivCo ChairmanGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    HALL GATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED23. Sept. 200701. Feb. 2017AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    BARRATTS TRADING LIMITED13. Jan. 201206. Dez. 2016AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritish
    THE HEPWORTH WAKEFIELD14. Mai 201324. Nov. 2016AktivChief ExecutiveGeschäftsführer
    Gallery Walk
    WF1 5AW Wakefield
    The Hepworth Wakefield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    TCS TRUSTEES LIMITED22. Juni 201024. Nov. 2016AktivDirectorGeschäftsführer
    The Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    Town Centre House
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    LEEDS INTERNATIONAL PIANOFORTE COMPETITION (ENTERPRISES) LTD23. Juni 199220. Nov. 2015AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    LONDON MACCABI RECREATIONAL TRUST06. Feb. 201405. Nov. 2015AktivConsultantGeschäftsführer
    c/o Lara Murray
    Rowley Lane
    EN5 3HW Barnet
    Rowley Lane Sports Ground
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish
    MACCABI FOUNDATION (THE)04. Okt. 200429. Aug. 2014AktivBusinessmanGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    DIRECT CONSUMER RETAIL LTD16. Jan. 201417. Jan. 2014AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    12
    Yorkshire
    England
    EnglandBritish
    UK ISRAEL BUSINESS12. Juli 200430. Nov. 2012AktivSekretär
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    British
    UK ISRAEL BUSINESS21. Mai 200330. Nov. 2012AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    APPERLEY BRIDGE LIMITED06. Mai 200910. Aug. 2012AktivDirectorGeschäftsführer
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 1NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    BRADFORD CITY CENTRE URC LIMITED06. Feb. 200331. Jan. 2010AufgelöstExecutive ChairmanGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    JEWISH CONTINUITY26. Nov. 199931. Juli 2006AktivDirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    HARRY HALL INTERNATIONAL LIMITED11. Juni 199116. Okt. 2000AktivGroup Managing DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    MATCHMAKERS INTERNATIONAL LIMITED07. Nov. 199501. Apr. 1997AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    MASTA RUG COMPANY LIMITED07. Nov. 199501. Apr. 1997AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Lake House 12 Lakeland Drive
    LS17 7PH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0