• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Peter John STUART - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornamePeter
    Zweites VornamenJohn
    NachnameSTUART
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv6
    Inaktiv2
    Zurückgetreten60
    Gesamt68

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    SUB-ATLANTIC LIMITED31. Juli 200801. Okt. 2010AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    PROSERV (1) LIMITED25. März 201021. Sept. 2010AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    1
    Angus
    ScotlandBritish
    NOV ELMAR (MIDDLE EAST) LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AktivManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    TUBOSCOPE VETCO CAPITAL LIMITED26. Okt. 199828. Feb. 2007AktivManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    NATIONAL OILWELL VARCO UK LIMITED28. Feb. 2007AktivManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    TOOLBOX DRILLING SOLUTIONS LIMITED07. Dez. 200628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    NOV UK FINANCE LIMITED30. Nov. 200528. Feb. 2007AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    MUD RECOVERY SYSTEMS LIMITED13. Juli 200428. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    MUD RENTALS LIMITED04. Nov. 200328. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    COIL SERVICES (NORTH SEA) LIMITED25. März 200228. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    MORINOAK INTERNATIONAL LIMITED11. Sept. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ELMAR SERVICES LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ELMAR RENTAL LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ELMAR SCREENS LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ELMAR CASING LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ELMAR ENGINEERING LIMITED31. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    VARCO (U.K.) LIMITED23. Aug. 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    VARCO UK ACQUISITIONS LIMITED06. Juni 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    RIG TECHNOLOGY LIMITED22. Mai 200128. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    HYDRA RIG UK LIMITED02. Dez. 199828. Feb. 2007AufgelöstManagaing DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    BRANDT COMPANY (U.K.) LIMITED (THE)29. Okt. 199828. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ENACO LIMITED01. Aug. 199728. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ENACO MUDCAT SYSTEMS LIMITED01. Aug. 199728. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    CHARGEWOOD LIMITED01. Aug. 199728. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    RECOVERY SYSTEMS LIMITED01. Aug. 199728. Feb. 2007AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    TUBOSCOPE PIPELINE SERVICES LIMITED14. Dez. 199628. Feb. 2007AufgelöstVice-PresidentGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    TUBOSCOPE HOLDINGS LIMITED13. Dez. 199628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    TUBOSCOPE VETCO (U.K.) LIMITED31. Okt. 199628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    PRESSURE CONTROL ENGINEERING LIMITED30. Sept. 199628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    S S R (INTERNATIONAL) LIMITED30. Sept. 199628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    ENVIRONMENTAL PROCEDURES (U.K.) LIMITED31. Jan. 199628. Feb. 2007AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    MONTROSE CHAMBER OF COMMERCE THE14. Apr. 199727. Mai 2003AktivMan DirGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish
    LINALOG LIMITED15. Dez. 199827. Juli 1999AufgelöstVice PresidentGeschäftsführer
    1 Rosehill Road
    DD10 8ST Montrose
    Angus
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0