Michael LAMONT
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Michael |
Nachname | LAMONT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 3 |
Zurückgetreten | 47 |
Gesamt | 50 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDFAST HOLDINGS LIMITED | 10. Juni 2019 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
SOUTHCROFT STRATEGY LIMITED | 17. Apr. 2019 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 79 Renfrew Road PA3 4DA Paisley Abercorn House Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | |
WILLIAM GRANT & SONS (2015) JERSEY CAPITAL V LIMITED | 09. Dez. 2015 | Umwandlung / Auflösung | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | |
SISKIN CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 23. Nov. 2020 | Umwandlung / Auflösung | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire | Scotland | British |
OSPREY CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 29. Okt. 2020 | Umwandlung / Auflösung | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS DUFFTOWN LIMITED | 02. Dez. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | AB55 4DH Dufftown, Keith The Glenfiddich Distillery | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS LIMITED | 20. Nov. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | Scotland | British |
QUALITY SPIRITS INTERNATIONAL LIMITED | 20. Nov. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Old Court House 7 Parkshot TW9 2RF Richmond William Grant & Sons England | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS GROUP LIMITED | 20. Nov. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS BRANDS LIMITED | 20. Nov. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Old Court House 7 Parkshot TW9 2RF Richmond William Grant & Sons England | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED | 20. Nov. 2019 | 04. Sept. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | Scotland | British |
CAPERCAILLIE CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 23. Juli 2020 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire | Scotland | British |
BRAMBLING CAPITAL (JERSEY) LIMITED | 09. Dez. 2015 | 16. März 2020 | Umwandlung / Auflösung | Accountant | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Phoenix Crescent Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British |
GEORGE MORTON LIMITED | 13. Apr. 2018 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Strathclyde Business Park Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde | Scotland | British |
DRAMBUIE LIQUEUR COMPANY LTD. (THE) | 05. Sept. 2014 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Customer Service Centre Lanarkshire Scotland | Scotland | British |
DRAMBUIE LIMITED | 05. Sept. 2014 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Phoenix Crescent Strathclyde Business Park ML4 3AN Bellshill Customer Service Centre Lanarkshire Scotland | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS BRANDS LIMITED | 28. Mai 2014 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Lower Mortlake Road TW9 2HS Richmond Independence House 84 Surrey United Kingdom | Scotland | British |
QUALITY SPIRITS INTERNATIONAL LIMITED | 31. Juli 2013 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Independence House 84 Lower Mortlake Road TW9 2HS Richmond Surrey | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS LIMITED | 15. Apr. 2013 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED | 15. Apr. 2013 | 01. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | Scotland | British |
WILLIAM GRANT & SONS GROUP LIMITED | 10. Apr. 2013 | 06. Aug. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dufftown AB55 4DH Keith The Glenfiddich Distillery Scotland | Scotland | British |
INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED | 02. Sept. 2008 | 20. Aug. 2012 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED | 02. Sept. 2008 | 20. Aug. 2012 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS (EUROPE) LIMITED | 02. Sept. 2008 | 20. Aug. 2012 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
BEN SHERMAN GROUP LIMITED | 11. Jan. 2001 | 27. Apr. 2007 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
RODEO INTERNATIONAL LIMITED | 15. Dez. 2006 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
BEN SHERMAN (MANUFACTURING) LIMITED | 11. Jan. 2001 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue Paisley PA2 7SP Scotland | Scotland | British |
BSGL1963 LIMITED | 11. Jan. 2001 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue Paisley PA2 7SP Scotland | Scotland | British |
BEN SHERMAN (LURGAN) LIMITED | 11. Jan. 2001 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue Paisley PA2 7SP Scotland | Scotland | British |
TERN SHIRTS LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
DUNKELD FASHIONS LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
SLIX LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
NEAL AND COOPER LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
BSL1963 LIMITED | 21. Nov. 2000 | 27. Apr. 2007 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | 20 South Avenue PA2 7SP Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0