BEN SHERMAN GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Ausländisches Unternehmen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBEN SHERMAN GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAusländische Gesellschaft
    Unternehmensnummer FC017612
    GerichtsbarkeitVereinigtes Königreich
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich BEN SHERMAN GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Miles Gray
    Ben Sherman Group Limited
    EC1R 5ET 2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell London
    Northern Ireland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BEN SHERMAN GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SHERMAN COOPER LIMITED07. Okt. 199307. Okt. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEN SHERMAN GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2008

    BEN SHERMAN GROUP LIMITED ist ein ausländisches Unternehmen

    Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen
    Art des ausländischen JahresabschlussesDie Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes gelten nicht
    Bedingungen für die Veröffentlichung des JahresabschlussesVon Companies House zugewiesenes Rechnungsabschlussreferenzdatum
    Ist ein Kredit- oder FinanzinstitutNein
    UrsprungsregisterlandNORTHERN IRELAND

    Welche sind die letzten Einreichungen für BEN SHERMAN GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Verschiedenes

    692(1)(B) Dir par 09/01/2008 paul tony fowler
    2 SeitenMISC

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2007

    19 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten692(1)(b)

    legacy

    3 Seiten692(1)(b)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2006

    19 SeitenAA

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2005

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten692(1)(b)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004

    19 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    14 Seiten692(1)(a)

    legacy

    3 Seiten692(1)(b)

    legacy

    4 Seiten692(1)(b)

    legacy

    3 Seiten692(1)(b)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2003

    17 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2002

    18 SeitenAA

    legacy

    SeitenFPA

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    legacy

    2 Seiten692(1)(b)

    Wer sind die Geschäftsführer von BEN SHERMAN GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REID, Allan Christopher
    37 Kirklands Crescent
    Bothwell
    G71 8HJ Glasgow
    South Lanarkshire
    Sekretär
    37 Kirklands Crescent
    Bothwell
    G71 8HJ Glasgow
    South Lanarkshire
    British83866820001
    CHODA, Jogesh
    9 Garland Hill
    BT8 6YL Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    9 Garland Hill
    BT8 6YL Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritish121436490001
    FOWLER, Paul Tony
    Woodland Grove
    Greenwich
    SE10 9UL London
    The Hayloft
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Woodland Grove
    Greenwich
    SE10 9UL London
    The Hayloft
    United Kingdom
    British121436550002
    GRAY, Miles Herbert
    Merrywind
    Stevens Lane, Claygate
    KT10 0TJ Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Merrywind
    Stevens Lane, Claygate
    KT10 0TJ Esher
    Surrey
    United KingdomBritish145148080001
    LAMONT, Michael
    26 Balgonie Avenue
    PA2 9LP Paisley
    Renfrewshire
    Sekretär
    26 Balgonie Avenue
    PA2 9LP Paisley
    Renfrewshire
    British49721170001
    WALKER, William Samuel
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    Sekretär
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    British145504680001
    GREEN, Michael Joseph
    17 Griffith Park
    Culmore Road
    BT48 8PE Londonderry
    Geschäftsführer
    17 Griffith Park
    Culmore Road
    BT48 8PE Londonderry
    United KingdomBritish143825650001
    HUDSON, Graham David
    Tall Trees Manor Avenue
    Goostrey
    CW4 8JA Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Tall Trees Manor Avenue
    Goostrey
    CW4 8JA Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritish58735650002
    LAMONT, Michael
    20 South Avenue
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    20 South Avenue
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish49721170002
    MCCRACKEN, Thomas Nelson Stewart
    13 Rowreagh Road
    Kircubbin
    BT22 1AT Newtownards
    County Down
    Geschäftsführer
    13 Rowreagh Road
    Kircubbin
    BT22 1AT Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish143916930001
    MCGOWAN-SMYTH, Robert William
    2 Glenview
    BT19 6NU Bangor
    County Down
    Geschäftsführer
    2 Glenview
    BT19 6NU Bangor
    County Down
    Northern IrelandIrish72343040001
    MILLS, Thomas Hamilton
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    Geschäftsführer
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish145863590001
    SATER, Roisen Mark
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    Geschäftsführer
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    British12462670003
    SIMPSON, Robert Dermott
    Glendermott House
    Dunnyvadden
    BT42 4HW Ballymena
    County Antrim
    Geschäftsführer
    Glendermott House
    Dunnyvadden
    BT42 4HW Ballymena
    County Antrim
    United KingdomBritish52444110003
    SOLOMONS, Bernard
    Levern Lodge, 22 Davieland Road
    Whitecraigs
    G46 7LL Glasgow
    Scotland
    Geschäftsführer
    Levern Lodge, 22 Davieland Road
    Whitecraigs
    G46 7LL Glasgow
    Scotland
    British18645550001
    STEWART, Robert Eric
    60 Amanda Close
    IG7 5JG Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    60 Amanda Close
    IG7 5JG Chigwell
    Essex
    British48197910001
    WALKER, William Samuel
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    Geschäftsführer
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    Northern IrelandBritish145504680001

    Hat BEN SHERMAN GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Licence to occupy
    Erstellt am 31. Juli 1997
    Geliefert am 13. Aug. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the licence to occupy
    Kurze Angaben
    Bank account containing £750.
    Berechtigte Personen
    • Cadogan Properties Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number 30099C/r/ptd/d date of policy 21/11/94 sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number 30442C/r/ptd/d date of policy 6/3/95 sum £500,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Life policy issued by k f alder at lloyds policy number 29610/r/ptd/D. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Life policy issued by k f alder life syndicate at lloyds policy no 30098C/r/ptd/d policy date 1/11/94 summ assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at maureen avenue londonderry northern ireland benefit of all rights licences contracts deeds undertakings assigns goodwill to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property ka/ portadown road lurgan all rights licences contracts deeds undertakings assigns goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 05. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    709 & 713A north circular road london t/no mx 52435 & MX207547 all rights licences contracts deeds undertakings assigns goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 29. Nov. 1993
    Geliefert am 07. Dez. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Kurze Angaben
    All monies due being £ 7,250 under the lease dated 29TH november 1993.
    Berechtigte Personen
    • Esjohn Properties Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of any agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a bellevue factory, londonderry in the parish of templemore, barony of north west liberties of londonderry and c/b of londonderry. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of any agreement or this charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings situate on the northern side of the north circular road, dollis hill, london and 713 and 713A north circular road, willesden, london t/nos: mx 52435 mx 207547 ngl 20091. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of any agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a bellevue factory, londonderry in the parish of templemore, barony of north west liberties of londonderry c/b of londonderry. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Department of Economic Development
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee,as trustee for the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever under the terms of any agreement or this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a bellevue factory, londonderry in the parish of templemore, barony of north west liberties of londonderry and c/b of londonderry. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neal and Cooper Limited (In Administrative Receivership)
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of any agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings situate on the northern side of the north circular road, dollis hill london and 713 and 713A north circular road, willesden, london t/nos: mx 52435 mx 207547 and ngl 20091. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Department of Economic Development
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 21. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All momies due or to become due from the company to the chargee, as trustee for the beneficiaries (as defined) on any account whatsoever under the terms of any agreement or this charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the northern side of north circular road, dollis hill, london and 713 and 713A north cicular road, willesden, london t/nos: mx 52435, mx 207547 and ngl 20091. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neal and Cooper Limited (In Administrative Receivership)
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0